BATEMAN CHAPMAN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBATEMAN CHAPMAN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01609862
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BATEMAN CHAPMAN LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BATEMAN CHAPMAN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Standard House
    12-13 Essex Street
    WC2R 3AA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BATEMAN CHAPMAN LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MATTHEWS BATEMAN LIMITED17 sept. 198217 sept. 1982
    SLYGOW LIMITED28 janv. 198228 janv. 1982

    Quels sont les derniers comptes de BATEMAN CHAPMAN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BATEMAN CHAPMAN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 27 janv. 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Nomination de Charles Taylor Administration Services Limited en tant que secrétaire

    3 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Robert Bird en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de International House 1 st Katharines Way London E1W 1UT le 05 janv. 2010

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    legacy

    3 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    9 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BATEMAN CHAPMAN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHARLES TAYLOR ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    Secrétaire
    Essex Street
    WC2R 3AA London
    Standard House 12-13
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3413040
    157558200001
    ELY, Thomas Damian
    9 Mayfield Avenue
    W4 1PN London
    Administrateur
    9 Mayfield Avenue
    W4 1PN London
    EnglandBritishInsurance Manager59348270003
    FITZSIMONS, George William
    30 Barrowfield
    Cuckfield
    RH17 5ER Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    30 Barrowfield
    Cuckfield
    RH17 5ER Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant105693390001
    BIRD, Robert Arthur
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    Secrétaire
    14 Coulsdon Rise
    CR5 2SA Coulsdon
    Surrey
    British23723280001
    DEAN, Margaret Ann
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    Secrétaire
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    British3390760001
    CHAPMAN, Dudley
    Blossom Hill
    OX29 7QZ Yelford
    Oxon
    Administrateur
    Blossom Hill
    OX29 7QZ Yelford
    Oxon
    United KingdomBritishLoss Adjuster3390770001
    CLARK, Christopher Alan
    5 Auton Place
    RG9 1LG Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    5 Auton Place
    RG9 1LG Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishLoss Adjuster3390780003
    DE LA SALLE, Trevor William
    55 Welsummer Way
    EN8 0UG Cheshunt
    Hertfordshire
    Administrateur
    55 Welsummer Way
    EN8 0UG Cheshunt
    Hertfordshire
    BritishInsurance Adjuster80683960001
    DEAN, Margaret Ann
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    6 Cotswold Meadow
    OX28 5FB Witney
    Oxfordshire
    BritishSecretary3390760001
    DYE, Christopher Howard
    30 West Grove
    KT12 5NX Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    30 West Grove
    KT12 5NX Walton On Thames
    Surrey
    BritishLoss Adjuster76449180001
    MASON, John
    Park Farm Oast
    Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Park Farm Oast
    Maresfield
    TN22 2EE Uckfield
    East Sussex
    BritishLoss Adjuster69478170001
    MCMAHON, Joseph
    Willows
    Guildford Lodge Drive
    KT24 6RJ East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Willows
    Guildford Lodge Drive
    KT24 6RJ East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishLoss Adjuster186218380001
    OINN, Martin Philip
    36 Saxon Way
    CB11 4EG Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    36 Saxon Way
    CB11 4EG Saffron Walden
    Essex
    BritishLoss Adjuster80683660001
    SMILLIE, James Brown
    Tusker House
    Lea
    SN16 9PG Malmesbury
    Administrateur
    Tusker House
    Lea
    SN16 9PG Malmesbury
    BritishLoss Adjuster3390800003
    VINER, David William
    6 Appledown Rise
    CR5 2DX Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    6 Appledown Rise
    CR5 2DX Coulsdon
    Surrey
    BritishLoss Adjuster80683820001

    BATEMAN CHAPMAN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 déc. 2005
    Livré le 16 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's right,title and interest from time to time in and to each of the following assets the real property,the tangible moveable property,the account,the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 16 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 juin 2004
    Livré le 21 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 1998
    Livré le 17 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 03 nov. 1995
    Livré le 08 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land and buildings at wycombe air park clay lane marlow buckinghamshire t/n bm 181526 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 nov. 1995
    Livré le 08 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 sept. 1986
    Livré le 12 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a factoring agreement.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Century Factors Limited
    Transactions
    • 12 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 22 août 1986
    Livré le 01 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0