MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01611047 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o ADDLESTONE KEANE G4 Whitehall Waterfront 2 Riverside Way LS1 4EH Leeds |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Per Stefan Andersson Tilk en tant que directeur le 15 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Divers Sect 519 | 1 pages | MISC | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Ashall en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Stacey Grayshon en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Goran Eklund le 16 avr. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O Addlestone Keane Carlton Tower 34 St. Pauls Street Leeds West Yorkshire LS1 2QB United Kingdom* le 24 févr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Rainey en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 19 pages | AA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed rommco (uk) LIMITED\certificate issued on 14/02/12 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Roadcare House New Works Road Low Moor Bradford BD12 0RU* le 10 févr. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAYSHON, Stacey | Secrétaire | c/o Addlestone Keane 2 Riverside Way LS1 4EH Leeds G4 Whitehall Waterfront | 187561000001 | |||||||
EKLUND, Goran | Administrateur | Vasagatan SE 411 24 Gothenburg 4 Sweden | Sweden | Swedish | Director | 155440620002 | ||||
ASHALL, Robert James | Secrétaire | Derry Hill Menston LS29 6NF Ilkley 16 West Yorkshire United Kingdom | 155441120001 | |||||||
HARRISON, Raymond George | Secrétaire | 39 Borrowdale Drive BB10 2SG Burnley Lancashire | British | 3815490001 | ||||||
HOLMBERG, Mats Ake | Secrétaire | Bolmortsvagen 4 29532 Bromolla Sweden | Swedish | Director | 48888860001 | |||||
KEANE, Mark Patrick | Secrétaire | The Grange Barn Moor Lane Kirkby Overblow HG3 1HU Harrogate | British | Solicitor | 96510470001 | |||||
ANDERSSON TILK, Per Stefan | Administrateur | Vastergardsvagen 43658 Havas 25 Sweden | Sweden | Swedish | Director | 155440480001 | ||||
BJORNEK, Anders | Administrateur | Hagenvagen 42 35 Kullavik Se 42935 Sweden | Swedish | Director | 88862600001 | |||||
BOARDMAN, Mark | Administrateur | 25 Moreton Drive MK18 1JG Buckingham Buckinghamshire | English | Director | 25107060001 | |||||
CAESAR, Anders Bertil | Administrateur | Lillesjovagen 7 S43040 Kungsbacka Sweden | Swedish | Director | 36593810001 | |||||
COTTHAM, John | Administrateur | 2 Mckenzie Close MK18 1SS Buckingham Buckinghamshire | English | Director | 25107070001 | |||||
DAWSON, Keith James | Administrateur | Wentsford House Aughton YO42 4PF York | British | Director | 3815510001 | |||||
HARRISON, Raymond George | Administrateur | 39 Borrowdale Drive BB10 2SG Burnley Lancashire | United Kingdom | British | Accountant | 3815490001 | ||||
HOLMBERG, Mats Ake | Administrateur | Bolmortsvagen 4 29532 Bromolla Sweden | Swedish | Director | 48888860001 | |||||
JOHNSTON, Douglas William | Administrateur | 9 Longdown Road CW12 4QH Congleton Cheshire | British | Director | 4474920002 | |||||
JONEGREN, Stig | Administrateur | Solbacken 34 Hoviksnas S-41762 Sweden | Swedish | Company Director | 64419520001 | |||||
LEWERTH, Lars | Administrateur | Drakenbergsgatan 6 S-41269 Gothenberg FOREIGN Sweden | Swedish | Company Director | 56707730001 | |||||
LJUNGKVIST, Hans Eric | Administrateur | Gavelasvagen 1, S433 31 Partille Sweeden | Sweden | Swedish | Director | 122458950001 | ||||
LJUNGKVIST, Hans Eric | Administrateur | Gavelasvagen 1, S433 31 Partille Sweeden | Sweden | Swedish | Director | 122458950001 | ||||
PRIOR, William Frederick | Administrateur | Lark Hill Parsons Road Heaton Bradford West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 32693180001 | ||||
RAINEY, John | Administrateur | 1 Ashwood Firwood Park OL9 9TR Oldham Lancashire | England | British | Company Director | 49947110001 | ||||
WALLDAL, Sigurd | Administrateur | Skarsgatan 36 S-41269 Gothenburg FOREIGN Sweden | Swedish | Company Director | 56707770001 | |||||
WOLFF, Nils Goran | Administrateur | Turnrosgatan 7 442 545 Ytterby FOREIGN Sweden | Swedish | Company Director | 53704750001 |
MARIEHOLM MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Créé le 05 oct. 1994 Livré le 07 oct. 1994 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings to the north side of new works road bradford west yorkshire t/n-WYK335497. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 mars 1994 Livré le 10 mars 1994 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture guarantee & off set | Créé le 04 juin 1990 Livré le 12 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (See 395 ref: M11 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 04 juin 1990 Livré le 08 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H-kiln farm employment area at milton keynes buckinghamshire and k/a unit 7 carters lane kiln farm milton keynes. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 19 sept. 1988 Livré le 06 oct. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 22 juin 1982 Livré le 28 juin 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. With all buildings fixture (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0