D J S CONTRACTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéD J S CONTRACTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01618855
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de D J S CONTRACTS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe D J S CONTRACTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de D J S CONTRACTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour D J S CONTRACTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour D J S CONTRACTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de * 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP* le 24 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juin 2013

    État du capital au 25 juin 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr Andrew Paul Gadsby en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Barnard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Nomination de Rbs Secretarial Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Amy Williamson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Amy Williamson en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Kirsty Daly en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    État du capital au 12 janv. 2012

    • Capital: GBP 1
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 23/12/2011
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de D J S CONTRACTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Secrétaire
    St. Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24-25
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC269847
    169073830001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish49141230004
    GADSBY, Andrew Paul
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Administrateur
    Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    135
    England
    EnglandBritish74834980002
    BROMLEY, Heidi Elizabeth
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    British33605720002
    CAMERON, Lindsey Helen
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Secrétaire
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Other132335590001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    DALY, Kirsty
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secrétaire
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    160697220001
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    British2289880001
    RODRIGUES, Michael Anthony
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    British29404660001
    STRANAGHAN, Patricia Ann
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    British39114460001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Secrétaire
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WILLIAMSON, Amy
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Secrétaire
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    166981780001
    WRAITH CARTER, Gillian
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    British109333000001
    BARNARD, Andrew David
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    Administrateur
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    EnglandBritish137736080001
    BEESTON, Alistair John
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    British10670790001
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    CUNDALL, David
    The Coppice
    Warren Lane
    BN8 4HX North Chailey
    East Sussex
    Administrateur
    The Coppice
    Warren Lane
    BN8 4HX North Chailey
    East Sussex
    British29404670001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Administrateur
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    JOHNSON, Jeffrey
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    British103077710001
    KAPUR, Neeraj
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    Administrateur
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    United KingdomBritish122158360001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Administrateur
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    POWELL, Martin Edward
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    Administrateur
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    United KingdomBritish59795080001
    RODRIGUES, Michael Anthony
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    Administrateur
    30 Tongdean Road
    BN3 6QE Hove
    East Sussex
    EnglandBritish29404660001
    ROOME, Harry Mccrea
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    Administrateur
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    EnglandBritish64898180001
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Administrateur
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritish67033830004

    D J S CONTRACTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 30 juil. 1990
    Livré le 06 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Old texaco depot, water lane, exeter, devon. Title no. Dn 169070; and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 26 avr. 1990
    Livré le 04 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever by virtue of the agreements and the loan agreements (as defined in the charge)
    Brèves mentions
    Fixed charge over all leasing agreements, all monies payable under such agreements, the goods comprised in the agreements, the benefit of all guarantees, indemnities and insurances etc. in connection with or relating to the agreements. (For full details see doc M98C).
    Personnes ayant droit
    • Standard Finance Limited and Ctl LTD.
    • Chartered Trust PLC, Chartered Leasing Limited, Ct Vehicle Leasing Limited
    Transactions
    • 04 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment & charge of sub letting agreements.
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 01 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal agreement
    Brèves mentions
    All the rights title and interest of the company in sub-leases in respert of goods, the benefit of all guarantees intermnities negotiable instruments & securities in connection with the sub-leases.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 01 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 13 juil. 1989
    Livré le 26 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed
    Créé le 12 mai 1989
    Livré le 26 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire/lease purchase or leasing agreements.
    Brèves mentions
    The benefit of all rights in, all monies due under all guarantees given all insurances effected pursuant to all hire or lease agreements.
    Personnes ayant droit
    • General Guarantee Corporation Limited
    Transactions
    • 26 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 02 janv. 1986
    Livré le 07 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights title & interest of the company in sub leases now or hereafter made by the company in respect of goods comprised in hp/leasing contract hire agreements now or hereafter made between the garage and the company tog. With the benefit of all guarantees, indemnities negotiable instruments & securities taken by the company in connection with the sub leases (see M15).
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company Limited.
    Transactions
    • 07 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 26 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 nov. 1983
    Livré le 01 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc 13). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 02 nov. 1982
    Livré le 09 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets present & future inc. Goodwill & bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 05 oct. 1982
    Livré le 12 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of existing sub-let agreements and of future sub-let agreements
    Brèves mentions
    Hire or leasing agreements now made or hereafter to be made by the company in respect of goods comprised in hire purchase or leisure agreements now or hereafter made between the company and either of the mortgages tog. With all monies from time to time becoming payable under each hire or leasing agreements (see doc M11).
    Personnes ayant droit
    • Bowmaker (Commercial) Limited and Bowmaker Leasing Limited
    Transactions
    • 12 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    • 17 août 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0