NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD

NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01629783
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ?

    Adresse du siège social
    10 Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THAMES VALE DEVELOPMENTS LIMITED19 avr. 198219 avr. 1982

    Quels sont les derniers comptes de NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kelly John Speller le 01 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 mars 2016

    État du capital au 09 mars 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kelly John Speller le 01 août 2015

    2 pagesCH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 31 mars 2016

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Jeremy Lobatto le 01 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Geoffrey King le 01 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas James Philip Bilsland le 01 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Susan Elizabeth Jacquest le 01 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Nicholas James Philip Bilsland le 01 déc. 2015

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de 1 Regius Court Church Road Penn High Wycombe Buckinghamshire HP10 8RL à 10 Penn Road Beaconsfield Buckinghamshire HP9 2LH le 27 juil. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2014

    9 pagesAA

    legacy

    31 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kelly John Speller le 29 juin 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Jeremy Lobatto le 29 juin 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Geoffrey King le 29 juin 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 févr. 2015

    État du capital au 17 févr. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    legacy

    34 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Qui sont les dirigeants de NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BILSLAND, Nicholas James Philip
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Secrétaire
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    British66511970002
    BILSLAND, Nicholas James Philip
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director66511970002
    JACQUEST, Susan Elizabeth
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishSales Director79924010004
    KING, Nicholas Geoffrey
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishManaging Director96115160006
    LOBATTO, Paul Jeremy
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishGroup Land Director78687810003
    SPELLER, Kelly John
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Penn Road
    HP9 2LH Beaconsfield
    10
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishTechnical Director73635390003
    BOUWMAN, Maria Wolmet
    Brooklyn House
    Curridge
    RG16 9DZ Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Brooklyn House
    Curridge
    RG16 9DZ Newbury
    Berkshire
    British33955300001
    CALDER, Paul Donald
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    Secrétaire
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    British5213990001
    KING, Nicholas Geoffrey
    Michaelmas House
    9 Dower Close Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Michaelmas House
    9 Dower Close Knotty Green
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British96115160002
    MERRY, Peter
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishFinancial Controller100620530001
    SMITHSON, Justine Helen
    19 Crown Cottage
    Cadley
    SN8 4NE Marlborough
    Wiltshire
    Secrétaire
    19 Crown Cottage
    Cadley
    SN8 4NE Marlborough
    Wiltshire
    BritishEstate Admin44758470001
    VARLEY, Gary David
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    Secrétaire
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    BritishFinance Director92647180001
    CALDER, Paul Donald
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    Administrateur
    The Sydings
    Speen
    RG14 1RZ Newbury
    5
    Berkshire
    EnglandBritishBuilding Consultant5213990001
    EASTHAM, Graeme Richard
    23 Trevelyan Place
    St Stephens Hill
    AL1 2DT St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    23 Trevelyan Place
    St Stephens Hill
    AL1 2DT St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishLand Director92379890001
    FAIRHURST, James Seton
    Shawdene House
    Shawdene
    RG16 9AJ Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Shawdene House
    Shawdene
    RG16 9AJ Newbury
    Berkshire
    BritishFarmer4303100001
    KING, Jane Carol
    Hughenden Chase
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hughenden Chase
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishDesign Director75532110001
    MERRY, Peter
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    82 Kings Ride
    Penn
    HP10 8BP High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishFinancial Controller100620530001
    MORAN, James Anthony
    101 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    101 Gregories Road
    HP9 1HZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishTechnical Director80790130001
    POTTER, David John
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Church Road
    HP10 8RL Penn
    No 1 Regius Court
    Buckinghamshire
    UkBritishSpecial Projects Director135413030001
    SIDLEY, Paul
    44 Micawber Avenue
    UB8 3NZ Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    44 Micawber Avenue
    UB8 3NZ Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritishConstruction Director100624730001
    VARLEY, Gary David
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    Administrateur
    68 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PR London
    BritishFinance Director92647180001
    NILPAD LIMITED
    The Quadrangle Enbourne Court
    Enbourne Road
    RG14 6AL Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Quadrangle Enbourne Court
    Enbourne Road
    RG14 6AL Newbury
    Berkshire
    42762730001

    NICHOLAS KING SPECIAL PROJECTS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 05 févr. 2009
    Livré le 12 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from playdri products limited and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land at thurston granray, station hill, thurston, bury st edmonds, suffolk t/no's SK180539, SK200526 and SK222270.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge on deposit account
    Créé le 09 oct. 2003
    Livré le 11 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All sums held to the credit of the company by the chargee at the date of the charge if any, the debts respectively represented by all other sums which shall in future from time to time be standing to the credit of the company with the chargee,.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 11 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 mai 2003
    Livré le 08 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Firstly by way of fixed charge over land at rear of 52 54 and 56 chestnut lane amersham buckinghamshire. Secondly by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time placed on or used in or about the above mentioned property.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 08 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 14 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    60 gore road burnham berks t/no: BM245980. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 14 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 sept. 2002
    Livré le 13 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The property k/a rose cottage, 58 chestnut lane, amersham, buckinghamshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 13 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Lulworth house ellesmere road weybridge surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Secured debenture
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Heritable Bank Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mars 2001
    Livré le 24 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land adoining 21 elm gardens claygate surrey.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 avr. 2000
    Livré le 21 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    16 18 20 bridge st leatherhead t/nos: SY336363 SY446734 SY357147 SY485260 SY550483 (part) and SY494073 (part). By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 21 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juin 1999
    Livré le 17 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at st philip,cheam common road,cheam common,worcester park,sutton,london borough of sutton.t/no sgl 608163.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juin 1999
    Livré le 17 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at the site of the former church of st philip cheam common,lindsay road,worcester park,london borough of sutton.t/no SGL608161.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 mai 1999
    Livré le 26 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 août 1997
    Livré le 28 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First the f/h and l/h property of the company wherever situate both present and future including but not limited to the specifically charged property being all that f/h land k/a 288 main road walters ash high wycombe and all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) and fittings from time to time on or in any such property and all rents and other income derived from any such property.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 28 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 1997
    Livré le 07 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all that f/h land situate at and k/a part of wattlefield speen lane newbury berkshire comprising part of the land under t/nos.BK223074, BK325460 and BK204608 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 07 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 avr. 1997
    Livré le 26 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land situate at and k/a land lying to the south west of newbold road speen t/no.BK340422.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 26 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 avr. 1997
    Livré le 12 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H risboro garage wycombe road princes risborough bucks and the assigns of goodwill to the bank. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 12 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Secured debenture
    Créé le 15 juil. 1996
    Livré le 18 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of floating security. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 18 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1996
    Livré le 18 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land comprising battle cottage speen lane speen newbury berks and adjoining land t/nos.BK280739 and BK245434. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 18 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1996
    Livré le 18 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land comprising larch close speen newbury berks t/nos.BK115012 BK260781 BK228292 and BK113862. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 18 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juil. 1996
    Livré le 18 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land comprising 20 station road thatcham newbury berks t/no.BK274330. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Heritable and General Investment Bank Limited
    Transactions
    • 18 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 janv. 1994
    Livré le 03 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a or being 2 larch close station road berks speen newbury berks t/n BK317735 and by way of assignment the goodwill of the business carried on at the mortgaged property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 janv. 1994
    Livré le 03 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a or being 1 larch close station road speen newbury berks BK317735 and by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on at the mortgaged property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 mai 1993
    Livré le 28 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property being 28 amberley close newbury berks and the right of all rentals payable. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit agreement
    Créé le 17 févr. 1993
    Livré le 03 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made the deposit means the debt or debts owing to the company by the bank or other party see c/h microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 10 déc. 1992
    Livré le 15 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All plant machinery chattels and other equipment set out on the schedule to form 395 see form 395 M13L for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 janv. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0