LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01632810 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Afiniti Limited 131-151 Great Titchfield Street W1W 5BB London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Duncan Coote en tant que directeur le 01 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neville Brauer en tant que directeur le 01 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Suite 8 Kd Tower Cotterells Hemel Hempstead Hertfordshire HP1 1FW à C/O Afiniti Limited 131-151 Great Titchfield Street London W1W 5BB le 18 mai 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Md Secretaries Limited en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2011 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 9 High Street Woburn Sands Milton Keynes Buckinghamshire MK17 8RF* le 08 juin 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan James Carmichael le 19 nov. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan James Carmichael le 19 nov. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARMICHAEL, Alan James | Administrateur | Bradford Road Heronsgate WD3 5DA Rickmansworth Mulberry Lodge Herts United Kingdom | United Kingdom | British | Director Of Operations | 33260960003 | ||||||||
MACFARLANE, David Archibald | Secrétaire | 4 Rosebery Street AB2 4LL Aberdeen | British | 37509080001 | ||||||||||
LEDINGHAM CHALMERS LLP | Secrétaire | Johnstone House 52-54 Rose Street AB10 1UD Aberdeen | 73896680003 | |||||||||||
MD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | c/o C/0 Mcgrigors Llp Bothwell Street G2 7EQ Glasgow 141 United Kingdom |
| 900005110001 | ||||||||||
BRAUER, Neville | Administrateur | The Lawn 5 Camden Park TN2 4TW Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Company Director | 107887020001 | ||||||||
BRAUER, Neville | Administrateur | The Lawn 5 Camden Park TN2 4TW Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | Company Director | 107887020001 | ||||||||
COOTE, Colin Duncan | Administrateur | 187 High St Stewkley LU7 0EX Leighton Buzzard Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 61737060002 | ||||||||
HARKIN, Neil Anthony | Administrateur | 2 Birch Avenue AB32 6RG Westhill Aberdeenshire | Scotland | Irish,British | Commercial Director | 72981980002 | ||||||||
HOUSTON, Donald John | Administrateur | 46 Myrtle Terrace Portlethen AB12 4SZ Aberdeen | British | Chartered Accountant | 45207780001 | |||||||||
JORGENSEN, Corrina Ann | Administrateur | 43 Grantham Road Chiswick W4 2RT London | British | Managing Director | 70211280002 | |||||||||
LAING, David Kemlo | Administrateur | 1 Golden Square AB10 1RB Aberdeen | British | Solicitor | 1372980009 | |||||||||
MACFARLANE, David Archibald | Administrateur | 4 Rosebery Street AB2 4LL Aberdeen | British | Finance Director | 37509080001 | |||||||||
MACKENZIE, Kenneth Macangus | Administrateur | Old Glassinghall FK15 0JG Dunblane Perthshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 107422780001 | ||||||||
MARMON, Kim | Administrateur | Blackhorse Cottage 3 Potton Road Guilden Morden SG8 0LB Royston Hertfordshire | British | Project Director | 72981910001 | |||||||||
PHILLIPS, George William | Administrateur | Carpestane House Carpestane EH39 North Berwick | British | Company Director | 33228030001 | |||||||||
PIPER, Anthony William | Administrateur | Kirkbride Fairseat Lane TN15 7LP Sevenoaks Kent | British | Company Director | 53717110001 | |||||||||
PORTER, Leonard Keith | Administrateur | 13 Braemar Place AB1 6EN Aberdeen Aberdeenshire | British | Company Director | 112160001 | |||||||||
ROWETT, Geoffrey David | Administrateur | 35 Allen House Park Hook Heath GU22 0DB Woking Surrey | British | Operations Director | 58991930002 | |||||||||
SMALL, Tony Russell | Administrateur | The Chestnuts Low Road NR13 3PA Wickhampton Norfolk | United Kingdom | British | Company Director | 61737080003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Alan James Carmichael | 06 avr. 2016 | Bradford Road Heronsgate WD3 5DA Rickmansworth Mulberry Lodge Hertfordshire United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Colin Duncan Coote | 06 avr. 2016 | Stewkley LU7 0EX Leighton Buzzard 187 High Street North Bedfordshire United Kingdom | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
|
LEARN-IT INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 05 avr. 1991 Livré le 11 avr. 1991 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 nov. 1987 Livré le 07 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 31 mai 1984 Livré le 13 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or mom international limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0