MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED

MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01633413
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Quay House
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Nomination de Mrs Penelope Ladkin-Brand en tant qu'administrateur le 09 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Oliver James Foster en tant qu'administrateur le 09 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Nial Ferguson en tant qu'administrateur le 09 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew James Burton en tant que directeur le 09 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Austin Haley en tant que directeur le 09 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Penelope Ladkin-Brand en tant que secrétaire le 09 juil. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Austin Haley en tant que secrétaire le 09 juil. 2015

    1 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 avr. 2015

    État du capital au 09 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagesSH20

    État du capital au 30 mars 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    3 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mr Richard Austin Haley en tant que secrétaire le 05 déc. 2014

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Nina Samantha Day en tant que secrétaire le 05 déc. 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Richard Austin Haley en tant qu'administrateur le 01 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Beauford Court 30 Monmouth Street Bath BA1 2BW à Quay House the Ambury Bath BA1 1UA le 01 août 2014

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    13 pagesAA

    Nomination de Mr. Matthew James Burton en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2014

    État du capital au 08 avr. 2014

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Graham Harding en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Zillah Ellen Byng-Maddick en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LADKIN-BRAND, Penelope
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Secrétaire
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    199242200001
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Administrateur
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    EnglandScottishDirector182681640001
    FERGUSON, Nial Terence
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Administrateur
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    EnglandBritishCompany Director188612770001
    FOSTER, Oliver James
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Administrateur
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    EnglandBritishManagement Accountant199325990001
    LADKIN-BRAND, Penelope
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    Administrateur
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    EnglandBritishCompany Director198181890001
    BURTON, Susannah Jane
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    Secrétaire
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    BritishFinance Director79959930001
    CAMPBELL, Tim
    7 Lawn Lane
    Little Downham
    CB6 2TS Ely
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    7 Lawn Lane
    Little Downham
    CB6 2TS Ely
    Cambridgeshire
    British54474070001
    DAY, Nina Samantha
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Secrétaire
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    175452310001
    HALEY, Richard Austin
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Secrétaire
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    193394060001
    LINKINS, Ian
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    Secrétaire
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    BritishCompany Director22968220002
    MILLAR, Mark Falcon
    Hollybush House
    Bannerdown Road Batheaston
    BA1 7ND Bath
    Bath And North East Somerset
    Secrétaire
    Hollybush House
    Bannerdown Road Batheaston
    BA1 7ND Bath
    Bath And North East Somerset
    British84701400002
    BOWMAN, John Reid
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    Administrateur
    5 Hamilton Road
    BA1 5SB Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandBritishFinance Director79292840001
    BURTON, Matthew James, Mr.
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Administrateur
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    WalesBritishGroup Financial Controller188612600001
    BURTON, Susannah Jane
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    Administrateur
    Shell Orchard
    The Street Chilcompton
    BA3 4HB Radstock
    Somerset
    BritishFinance Director79959930001
    DAY, Terence Albert
    97 New Road
    Haslingfield
    CB3 7LP Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    97 New Road
    Haslingfield
    CB3 7LP Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishPublisher1500970001
    HALEY, Richard Austin
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    Administrateur
    The Ambury
    BA1 1UA Bath
    Quay House
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer191702530001
    HARDING, Graham David
    Beauford Court
    30 Monmouth Street
    BA1 2BW Bath
    Administrateur
    Beauford Court
    30 Monmouth Street
    BA1 2BW Bath
    EnglandBritishFinance Director97729390001
    HILL, Dennis William
    12 Mill Hill End
    Hilton
    PE28 9NX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    12 Mill Hill End
    Hilton
    PE28 9NX Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishPublisher1464090001
    INGHAM, Gregory John
    Avonstone
    Bathampton Lane Bathampton
    BA2 6SW Bath
    Administrateur
    Avonstone
    Bathampton Lane Bathampton
    BA2 6SW Bath
    United KingdomBritishDirector109991380001
    LINKINS, Ian
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    Administrateur
    Hackless House Murhill
    Limpley Stoke
    BA3 6HH Bath
    BritishCompany Director22968220002

    MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 24 juil. 1989
    Livré le 10 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H alexander house, (formerly k/as kingfisher house) ely, cambs. Goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 17 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 15 juin 1989
    Livré le 19 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 02 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 nov. 1988
    Livré le 16 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1988
    Livré le 13 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    32 mulberry way ely, cambridgeshire together with all buildings and fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 17 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 nov. 1986
    Livré le 27 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 30 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 1983
    Livré le 04 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 1983Enregistrement d'une charge
    • 30 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0