MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01633413 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?
Adresse du siège social | Quay House The Ambury BA1 1UA Bath |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomination de Mrs Penelope Ladkin-Brand en tant qu'administrateur le 09 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Oliver James Foster en tant qu'administrateur le 09 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Nial Ferguson en tant qu'administrateur le 09 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew James Burton en tant que directeur le 09 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Austin Haley en tant que directeur le 09 juil. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Penelope Ladkin-Brand en tant que secrétaire le 09 juil. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Austin Haley en tant que secrétaire le 09 juil. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 30 mars 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Richard Austin Haley en tant que secrétaire le 05 déc. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nina Samantha Day en tant que secrétaire le 05 déc. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Austin Haley en tant qu'administrateur le 01 oct. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Beauford Court 30 Monmouth Street Bath BA1 2BW à Quay House the Ambury Bath BA1 1UA le 01 août 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2013 | 13 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr. Matthew James Burton en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Harding en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Zillah Ellen Byng-Maddick en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADKIN-BRAND, Penelope | Secrétaire | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | 199242200001 | |||||||
BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | Scottish | Director | 182681640001 | ||||
FERGUSON, Nial Terence | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | England | British | Company Director | 188612770001 | ||||
FOSTER, Oliver James | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | England | British | Management Accountant | 199325990001 | ||||
LADKIN-BRAND, Penelope | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House | England | British | Company Director | 198181890001 | ||||
BURTON, Susannah Jane | Secrétaire | Shell Orchard The Street Chilcompton BA3 4HB Radstock Somerset | British | Finance Director | 79959930001 | |||||
CAMPBELL, Tim | Secrétaire | 7 Lawn Lane Little Downham CB6 2TS Ely Cambridgeshire | British | 54474070001 | ||||||
DAY, Nina Samantha | Secrétaire | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 175452310001 | |||||||
HALEY, Richard Austin | Secrétaire | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | 193394060001 | |||||||
LINKINS, Ian | Secrétaire | Hackless House Murhill Limpley Stoke BA3 6HH Bath | British | Company Director | 22968220002 | |||||
MILLAR, Mark Falcon | Secrétaire | Hollybush House Bannerdown Road Batheaston BA1 7ND Bath Bath And North East Somerset | British | 84701400002 | ||||||
BOWMAN, John Reid | Administrateur | 5 Hamilton Road BA1 5SB Bath Bath And North East Somerset | England | British | Finance Director | 79292840001 | ||||
BURTON, Matthew James, Mr. | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | Wales | British | Group Financial Controller | 188612600001 | ||||
BURTON, Susannah Jane | Administrateur | Shell Orchard The Street Chilcompton BA3 4HB Radstock Somerset | British | Finance Director | 79959930001 | |||||
DAY, Terence Albert | Administrateur | 97 New Road Haslingfield CB3 7LP Cambridge Cambridgeshire | British | Publisher | 1500970001 | |||||
HALEY, Richard Austin | Administrateur | The Ambury BA1 1UA Bath Quay House England | England | British | Chief Financial Officer | 191702530001 | ||||
HARDING, Graham David | Administrateur | Beauford Court 30 Monmouth Street BA1 2BW Bath | England | British | Finance Director | 97729390001 | ||||
HILL, Dennis William | Administrateur | 12 Mill Hill End Hilton PE28 9NX Huntingdon Cambridgeshire | England | British | Publisher | 1464090001 | ||||
INGHAM, Gregory John | Administrateur | Avonstone Bathampton Lane Bathampton BA2 6SW Bath | United Kingdom | British | Director | 109991380001 | ||||
LINKINS, Ian | Administrateur | Hackless House Murhill Limpley Stoke BA3 6HH Bath | British | Company Director | 22968220002 |
MUSIC MAKER PUBLICATIONS (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 24 juil. 1989 Livré le 10 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H alexander house, (formerly k/as kingfisher house) ely, cambs. Goodwill.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 15 juin 1989 Livré le 19 juin 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 01 nov. 1988 Livré le 16 nov. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 24 juin 1988 Livré le 13 juil. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 32 mulberry way ely, cambridgeshire together with all buildings and fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 16 nov. 1986 Livré le 27 nov. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 juil. 1983 Livré le 04 août 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0