BROADREACH HOUSE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROADREACH HOUSE
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 01634415
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROADREACH HOUSE ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale
    • Activités de soins résidentiels pour troubles d'apprentissage, santé mentale et abus de substances (87200) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe BROADREACH HOUSE ?

    Adresse du siège social
    C/O Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BROADREACH HOUSE ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mai 2019
    Date d'échéance des prochains comptes29 févr. 2020
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2018

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BROADREACH HOUSE ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au06 nov. 2019
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation20 nov. 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au06 nov. 2018
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour BROADREACH HOUSE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2024

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2023

    16 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2022

    14 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2021

    14 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    17 pagesAM22

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    18 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC

    20 pagesAM02

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    41 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de 465 Tavistock Road Plymouth Devon PL6 7HE England à C/O Centenary House Peninsula Park Rydon Lane Exeter EX2 7XE le 25 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Cessation de la nomination de John Joseph Kiddey en tant que directeur le 23 mai 2019

    1 pagesTM01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10

    2 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10

    2 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 016344150015

    1 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10

    2 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 9

    1 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 8

    1 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 016344150013

    1 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 11

    2 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 016344150013

    1 pagesMR05

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10

    2 pagesMR05

    Qui sont les dirigeants de BROADREACH HOUSE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DYER, Cynthia Wendy
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    Devon
    England
    Secrétaire
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    Devon
    England
    185922460001
    DORMER, Georgina
    Barton Road
    Badersfield
    NR10 5JR Norwich
    58
    England
    Administrateur
    Barton Road
    Badersfield
    NR10 5JR Norwich
    58
    England
    United KingdomBritishChief Executive239804390002
    GAVIN, Christina Saunders
    Barton
    Harbertonford
    TQ9 7UE Totnes
    Lower Washbourne
    Devon
    England
    Administrateur
    Barton
    Harbertonford
    TQ9 7UE Totnes
    Lower Washbourne
    Devon
    England
    United KingdomAmericanNone164385900001
    HAYES, Raymond Charles Svend O'Connell
    Buttville House
    Derby Road
    TQ7 1JL Kingsbridge
    Devon
    Administrateur
    Buttville House
    Derby Road
    TQ7 1JL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritishSolicitor60313380001
    JONES, Timothy Michael
    Langmeads
    Belstone
    EX20 1RA Okehampton
    Devon
    Administrateur
    Langmeads
    Belstone
    EX20 1RA Okehampton
    Devon
    EnglandBritishChartered Surveyor32775520001
    KITSON, James Buller
    Botus Fleming
    Saltash
    Churchtown
    Cornwall
    United Kingdom
    Administrateur
    Botus Fleming
    Saltash
    Churchtown
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant160122150001
    LOFTUS, Christopher John
    Grammont Parsonage Road
    Newton Ferrers
    PL8 1AT Plymouth
    Devon
    Administrateur
    Grammont Parsonage Road
    Newton Ferrers
    PL8 1AT Plymouth
    Devon
    EnglandBritishChartered Accountant16148490001
    MARSHALL, Craig Rodger
    Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    C/O Centenary House
    Administrateur
    Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    C/O Centenary House
    EnglandBritishTraining Manager107987460001
    WALKER, Andrew Donaldson
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    Secrétaire
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    British22986190001
    WALLACE, Judith Thaddeus
    Langdale 19 Tavistock Road
    PL5 3DG Plymouth
    Devon
    Secrétaire
    Langdale 19 Tavistock Road
    PL5 3DG Plymouth
    Devon
    British9615430001
    WARD, Richard Edmund
    Fieldhead New Road
    PL14 4HB Liskeard
    Cornwall
    Secrétaire
    Fieldhead New Road
    PL14 4HB Liskeard
    Cornwall
    British46147030002
    ADAMS, Peter John
    Ballyholme
    Manor Bourne Down Thomas
    PL9 0AS Plymouth
    Administrateur
    Ballyholme
    Manor Bourne Down Thomas
    PL9 0AS Plymouth
    BritishCivil Engineer10484340002
    ADEY, John Victor
    The Old Cellar
    Stoney Stratton
    BA4 6EA Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    The Old Cellar
    Stoney Stratton
    BA4 6EA Shepton Mallet
    Somerset
    BritishGroup Treasurer50847880002
    BADGE, Peter Gilmour Noto, Sir
    6 Springfield
    Bedford Road
    PL20 7QS Horrabridge
    Devon
    Administrateur
    6 Springfield
    Bedford Road
    PL20 7QS Horrabridge
    Devon
    EnglandBritishRetired Chief Metropolitan Mag108248270001
    BERNSTEIN, David Sidney, The Hon
    27 Tregunter Road
    SW10 9LS London
    Administrateur
    27 Tregunter Road
    SW10 9LS London
    BritishCompany Director5096490001
    FENWICK, Sebastian Edmund Stephen
    Shilstone
    Modbury
    PL21 0TW Ivybridge
    Devon
    Administrateur
    Shilstone
    Modbury
    PL21 0TW Ivybridge
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director126801890001
    GAVIN, Christina Saunders
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    Administrateur
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    United KingdomAmericanNone164385900001
    GEORGAKIS, Phillip
    Flat 3 Hyde Park Gardens
    W2 2NB London
    Administrateur
    Flat 3 Hyde Park Gardens
    W2 2NB London
    BritishEconomist22986210001
    HERBERT, Edward
    1 Perches Close
    Newton Ferrers
    PL8 1HZ Plymouth
    Devon
    Administrateur
    1 Perches Close
    Newton Ferrers
    PL8 1HZ Plymouth
    Devon
    BritishRetired22986220001
    HUGHES, Lorraine Roberta
    Vereley House
    BH24 4HH Ringwood
    Hampshire
    Administrateur
    Vereley House
    BH24 4HH Ringwood
    Hampshire
    BritishKindergarten Owner106702040001
    KIDDEY, John Joseph
    15 Whidborne Avenue
    TQ1 2PG Torquay
    Devon
    Administrateur
    15 Whidborne Avenue
    TQ1 2PG Torquay
    Devon
    EnglandBritishRetired99411650001
    LEICESTER-THACKARA, James Antony
    157-159 Fore Street
    PL12 6AB Saltash
    Cornwall
    Administrateur
    157-159 Fore Street
    PL12 6AB Saltash
    Cornwall
    BritishChartered Accountant4927450001
    LEICESTER-THACKARA, Vanessa J
    Rivermead House
    Two Waters Foot
    PL14 6HT Liskeard
    Cornwall
    Administrateur
    Rivermead House
    Two Waters Foot
    PL14 6HT Liskeard
    Cornwall
    BritishCompany Director12875110002
    LOPES, Henry Massey, The Hon
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    Administrateur
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    BritishChartered Surveyor24683680001
    LOPES, Jean Campbell Sorell, The Hon
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    Administrateur
    Bickham House
    Roborough
    PL6 7BL Plymouth
    Devon
    EnglandAustralianNone106953490001
    MASSEY, Charlotte, Dr
    c/o Mrs Cynthia Dyer
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    England
    Administrateur
    c/o Mrs Cynthia Dyer
    Tavistock Road
    PL6 7HE Plymouth
    465
    England
    EnglandBritishRetired Gp223578560001
    MORGAN, Heather Margaret
    40 Countess Wear Road
    EX2 6LR Exeter
    Devon
    Administrateur
    40 Countess Wear Road
    EX2 6LR Exeter
    Devon
    EnglandEnglishSolicitor79971780001
    PROSSER, Sarah Louise
    165 Alma Road
    Milehouse
    PL3 4HQ Plymouth
    Devon
    Administrateur
    165 Alma Road
    Milehouse
    PL3 4HQ Plymouth
    Devon
    BritishSales Director58450550003
    ROWELL, Oliver John
    Little Calumet Sandy Lane
    Ivy Hatch
    TN15 0PD Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Little Calumet Sandy Lane
    Ivy Hatch
    TN15 0PD Sevenoaks
    Kent
    BritishRetired General Manager12287310001
    SCHIFFMANN, Sybille Erika
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    Administrateur
    Ocean Quay
    Richmond Walk
    PL1 4LL Plymouth
    Unit 2
    Devon
    EnglandIrishLeadership Consultant127456240001
    SEWELL, Michael Arthur
    Hartley Villa 157 Mannamead Road
    PL3 5NU Plymouth
    Devon
    Administrateur
    Hartley Villa 157 Mannamead Road
    PL3 5NU Plymouth
    Devon
    BritishRetired6636210001
    URWIN, Peter John Michael
    Myrtle Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NQ Saltash
    Cornwall
    Administrateur
    Myrtle Cottage
    Botus Fleming
    PL12 6NQ Saltash
    Cornwall
    EnglandBritishMedical Practitioner125967650001
    WAKEFIELD, David Anthony
    53 Ringford Road
    SW18 1RP London
    Administrateur
    53 Ringford Road
    SW18 1RP London
    United KingdomBritishNon Executive Director8047330001
    WALKER, Andrew Donaldson
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    Administrateur
    Lantallock Farm
    Landrake
    Saltash
    Cornwall
    BritishSolicitor22986190001
    WILKINSON, Peter
    Public Health Laboratory Service
    Derriford Hospital
    PL6 8DH Plymouth
    Devon
    Administrateur
    Public Health Laboratory Service
    Derriford Hospital
    PL6 8DH Plymouth
    Devon
    BritishMedical Microbiologist22986250001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BROADREACH HOUSE ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 nov. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    BROADREACH HOUSE a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 janv. 2019
    Livré le 16 janv. 2019
    En cours
    Brève description
    All of the freehold property known as long reach house registered as vescourt cottage, hartley road, plymouth PL3 5LW registered under title number DN363827.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Belstone Fox Limited
    Transactions
    • 16 janv. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 juin 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2018
    Livré le 17 déc. 2018
    En cours
    Brève description
    All that freehold land and buildings known as 465 tavistock road, plymouth as registered with title absolute at the land registry under title number DN62025.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Futurebuilders England Limited
    Transactions
    • 17 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2015
    Livré le 08 déc. 2015
    En cours
    Brève description
    The old grammar school longcause plympton t/n DN579260.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees for the Time Being of Heles Exhibition Foundation at Plympton
    Transactions
    • 08 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 juin 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Mortgage
    Créé le 21 oct. 2010
    Livré le 23 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a closereach longcause plympton st maurice plymouth devon t/no. DN59004 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 avr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 12 sept. 2007
    Livré le 20 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 2 ocean quay richmonds walk plymouth t/no DN213497 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Mortgage
    Créé le 12 sept. 2007
    Livré le 20 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 ocean way richmond walk plymouth devon t/no DN213498 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juin 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Charge over property
    Créé le 12 sept. 2007
    Livré le 14 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the west side or richmond walk stonehouse plymouth t/n DN213498 together with all rights.
    Personnes ayant droit
    • Futurebuilders England Limited
    Transactions
    • 14 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 16 avr. 2007
    Livré le 17 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Unit 2 ocean quay richmond walk plymouth.
    Personnes ayant droit
    • Futurebuilders England Limited
    Transactions
    • 17 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal mortgage
    Créé le 15 déc. 1989
    Livré le 21 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H old grammar school house, george lane, plympton, st maurice plympton, plymouth, t/n dn 59004 goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 29 nov. 1989
    Livré le 30 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being 465 tavistock road, plymouth t/n dn 62025 and all buildings & fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 15 août 1988
    Livré le 22 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Wilmore 465 tavistock road, plymouth devon t/n dn 62025 and the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 28 juil. 1988
    Livré le 05 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Old grammar school house george land plympton st maurice plymouth devon t/n dn 59004 and/or the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed
    Créé le 31 déc. 1982
    Livré le 13 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 25/5/82 and a charge dated 25/5/82
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and working capital f/h wilmore, 465 tavistock road, plymouth devon title no: dn 62025.
    Personnes ayant droit
    • Bupa Investments LTD
    Transactions
    • 13 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 28 mai 1982
    Livré le 09 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Wilmore, 465 tavistock road, plymouth, title no. Dn 62025.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juin 1982Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 28 mai 1982
    Livré le 09 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 25/5/82
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital wilmore, 465 tavistock road, roborough, plymouth title no dn 62025.
    Personnes ayant droit
    • Bupa Investments Limited
    Transactions
    • 09 juin 1982Enregistrement d'une charge
    • 14 oct. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BROADREACH HOUSE a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 juil. 2019Administration started
    14 août 2020Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lucinda Clare Coleman
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    practitioner
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Stephen James Hobson
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    practitioner
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    2
    DateType
    14 août 2020Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lucinda Clare Coleman
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    practitioner
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    Stephen James Hobson
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter
    practitioner
    Centenary House Peninsula Park
    Rydon Lane
    EX2 7XE Exeter

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0