BROADREACH HOUSE
Vue d'ensemble
Nom de la société | BROADREACH HOUSE |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
Numéro de société | 01634415 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BROADREACH HOUSE ?
Adresse du siège social | C/O Centenary House Peninsula Park Rydon Lane EX2 7XE Exeter |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BROADREACH HOUSE ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mai 2019 |
Date d'échéance des prochains comptes | 29 févr. 2020 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mai 2018 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BROADREACH HOUSE ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 nov. 2019 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 20 nov. 2019 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 nov. 2018 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour BROADREACH HOUSE ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2024 | 15 pages | LIQ03 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2023 | 16 pages | LIQ03 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2022 | 14 pages | LIQ03 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2021 | 14 pages | LIQ03 | ||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 19 pages | AM10 | ||
Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers | 17 pages | AM22 | ||
Avis de prolongation de la période de l'administration | 3 pages | AM19 | ||
Rapport d'avancement de l'administrateur | 18 pages | AM10 | ||
Avis d'approbation réputée des propositions | 3 pages | AM06 | ||
Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA/AM02SOC | 20 pages | AM02 | ||
Déclaration de la proposition de l'administrateur | 41 pages | AM03 | ||
Changement d'adresse du siège social de 465 Tavistock Road Plymouth Devon PL6 7HE England à C/O Centenary House Peninsula Park Rydon Lane Exeter EX2 7XE le 25 juil. 2019 | 2 pages | AD01 | ||
Nomination d'un administrateur | 3 pages | AM01 | ||
Cessation de la nomination de John Joseph Kiddey en tant que directeur le 23 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10 | 2 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10 | 2 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 016344150015 | 1 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10 | 2 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 9 | 1 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 8 | 1 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 016344150013 | 1 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 11 | 2 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 016344150013 | 1 pages | MR05 | ||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 10 | 2 pages | MR05 | ||
Qui sont les dirigeants de BROADREACH HOUSE ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYER, Cynthia Wendy | Secrétaire | Tavistock Road PL6 7HE Plymouth 465 Devon England | 185922460001 | |||||||
DORMER, Georgina | Administrateur | Barton Road Badersfield NR10 5JR Norwich 58 England | United Kingdom | British | Chief Executive | 239804390002 | ||||
GAVIN, Christina Saunders | Administrateur | Barton Harbertonford TQ9 7UE Totnes Lower Washbourne Devon England | United Kingdom | American | None | 164385900001 | ||||
HAYES, Raymond Charles Svend O'Connell | Administrateur | Buttville House Derby Road TQ7 1JL Kingsbridge Devon | England | British | Solicitor | 60313380001 | ||||
JONES, Timothy Michael | Administrateur | Langmeads Belstone EX20 1RA Okehampton Devon | England | British | Chartered Surveyor | 32775520001 | ||||
KITSON, James Buller | Administrateur | Botus Fleming Saltash Churchtown Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 160122150001 | ||||
LOFTUS, Christopher John | Administrateur | Grammont Parsonage Road Newton Ferrers PL8 1AT Plymouth Devon | England | British | Chartered Accountant | 16148490001 | ||||
MARSHALL, Craig Rodger | Administrateur | Peninsula Park Rydon Lane EX2 7XE Exeter C/O Centenary House | England | British | Training Manager | 107987460001 | ||||
WALKER, Andrew Donaldson | Secrétaire | Lantallock Farm Landrake Saltash Cornwall | British | 22986190001 | ||||||
WALLACE, Judith Thaddeus | Secrétaire | Langdale 19 Tavistock Road PL5 3DG Plymouth Devon | British | 9615430001 | ||||||
WARD, Richard Edmund | Secrétaire | Fieldhead New Road PL14 4HB Liskeard Cornwall | British | 46147030002 | ||||||
ADAMS, Peter John | Administrateur | Ballyholme Manor Bourne Down Thomas PL9 0AS Plymouth | British | Civil Engineer | 10484340002 | |||||
ADEY, John Victor | Administrateur | The Old Cellar Stoney Stratton BA4 6EA Shepton Mallet Somerset | British | Group Treasurer | 50847880002 | |||||
BADGE, Peter Gilmour Noto, Sir | Administrateur | 6 Springfield Bedford Road PL20 7QS Horrabridge Devon | England | British | Retired Chief Metropolitan Mag | 108248270001 | ||||
BERNSTEIN, David Sidney, The Hon | Administrateur | 27 Tregunter Road SW10 9LS London | British | Company Director | 5096490001 | |||||
FENWICK, Sebastian Edmund Stephen | Administrateur | Shilstone Modbury PL21 0TW Ivybridge Devon | United Kingdom | British | Company Director | 126801890001 | ||||
GAVIN, Christina Saunders | Administrateur | Ocean Quay Richmond Walk PL1 4LL Plymouth Unit 2 Devon | United Kingdom | American | None | 164385900001 | ||||
GEORGAKIS, Phillip | Administrateur | Flat 3 Hyde Park Gardens W2 2NB London | British | Economist | 22986210001 | |||||
HERBERT, Edward | Administrateur | 1 Perches Close Newton Ferrers PL8 1HZ Plymouth Devon | British | Retired | 22986220001 | |||||
HUGHES, Lorraine Roberta | Administrateur | Vereley House BH24 4HH Ringwood Hampshire | British | Kindergarten Owner | 106702040001 | |||||
KIDDEY, John Joseph | Administrateur | 15 Whidborne Avenue TQ1 2PG Torquay Devon | England | British | Retired | 99411650001 | ||||
LEICESTER-THACKARA, James Antony | Administrateur | 157-159 Fore Street PL12 6AB Saltash Cornwall | British | Chartered Accountant | 4927450001 | |||||
LEICESTER-THACKARA, Vanessa J | Administrateur | Rivermead House Two Waters Foot PL14 6HT Liskeard Cornwall | British | Company Director | 12875110002 | |||||
LOPES, Henry Massey, The Hon | Administrateur | Bickham House Roborough PL6 7BL Plymouth Devon | British | Chartered Surveyor | 24683680001 | |||||
LOPES, Jean Campbell Sorell, The Hon | Administrateur | Bickham House Roborough PL6 7BL Plymouth Devon | England | Australian | None | 106953490001 | ||||
MASSEY, Charlotte, Dr | Administrateur | c/o Mrs Cynthia Dyer Tavistock Road PL6 7HE Plymouth 465 England | England | British | Retired Gp | 223578560001 | ||||
MORGAN, Heather Margaret | Administrateur | 40 Countess Wear Road EX2 6LR Exeter Devon | England | English | Solicitor | 79971780001 | ||||
PROSSER, Sarah Louise | Administrateur | 165 Alma Road Milehouse PL3 4HQ Plymouth Devon | British | Sales Director | 58450550003 | |||||
ROWELL, Oliver John | Administrateur | Little Calumet Sandy Lane Ivy Hatch TN15 0PD Sevenoaks Kent | British | Retired General Manager | 12287310001 | |||||
SCHIFFMANN, Sybille Erika | Administrateur | Ocean Quay Richmond Walk PL1 4LL Plymouth Unit 2 Devon | England | Irish | Leadership Consultant | 127456240001 | ||||
SEWELL, Michael Arthur | Administrateur | Hartley Villa 157 Mannamead Road PL3 5NU Plymouth Devon | British | Retired | 6636210001 | |||||
URWIN, Peter John Michael | Administrateur | Myrtle Cottage Botus Fleming PL12 6NQ Saltash Cornwall | England | British | Medical Practitioner | 125967650001 | ||||
WAKEFIELD, David Anthony | Administrateur | 53 Ringford Road SW18 1RP London | United Kingdom | British | Non Executive Director | 8047330001 | ||||
WALKER, Andrew Donaldson | Administrateur | Lantallock Farm Landrake Saltash Cornwall | British | Solicitor | 22986190001 | |||||
WILKINSON, Peter | Administrateur | Public Health Laboratory Service Derriford Hospital PL6 8DH Plymouth Devon | British | Medical Microbiologist | 22986250001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BROADREACH HOUSE ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
06 nov. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
BROADREACH HOUSE a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 03 janv. 2019 Livré le 16 janv. 2019 | En cours | ||
Brève description All of the freehold property known as long reach house registered as vescourt cottage, hartley road, plymouth PL3 5LW registered under title number DN363827. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 17 déc. 2018 Livré le 17 déc. 2018 | En cours | ||
Brève description All that freehold land and buildings known as 465 tavistock road, plymouth as registered with title absolute at the land registry under title number DN62025. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 01 déc. 2015 Livré le 08 déc. 2015 | En cours | ||
Brève description The old grammar school longcause plympton t/n DN579260. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 21 oct. 2010 Livré le 23 oct. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a closereach longcause plympton st maurice plymouth devon t/no. DN59004 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 12 sept. 2007 Livré le 20 sept. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a unit 2 ocean quay richmonds walk plymouth t/no DN213497 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 12 sept. 2007 Livré le 20 sept. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a unit 1 ocean way richmond walk plymouth devon t/no DN213498 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over property | Créé le 12 sept. 2007 Livré le 14 sept. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings on the west side or richmond walk stonehouse plymouth t/n DN213498 together with all rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 avr. 2007 Livré le 17 avr. 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Unit 2 ocean quay richmond walk plymouth. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 15 déc. 1989 Livré le 21 déc. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H old grammar school house, george lane, plympton, st maurice plympton, plymouth, t/n dn 59004 goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 29 nov. 1989 Livré le 30 nov. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a or being 465 tavistock road, plymouth t/n dn 62025 and all buildings & fixtures the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 15 août 1988 Livré le 22 août 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Wilmore 465 tavistock road, plymouth devon t/n dn 62025 and the proceeds of sale thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 28 juil. 1988 Livré le 05 août 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Old grammar school house george land plympton st maurice plymouth devon t/n dn 59004 and/or the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 31 déc. 1982 Livré le 13 janv. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 25/5/82 and a charge dated 25/5/82 | |
Brèves mentions Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and working capital f/h wilmore, 465 tavistock road, plymouth devon title no: dn 62025. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 28 mai 1982 Livré le 09 juin 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Wilmore, 465 tavistock road, plymouth, title no. Dn 62025. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 28 mai 1982 Livré le 09 juin 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 25/5/82 | |
Brèves mentions Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital wilmore, 465 tavistock road, roborough, plymouth title no dn 62025. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
BROADREACH HOUSE a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In administration |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0