SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED

SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01634992
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sca Packaging Finance Shared
    Service Centre Faverdale
    DL3 0PE Faverdale Industrial Estate
    Darlington Co Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED12 mai 198212 mai 1982

    Quels sont les derniers comptes de SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 sept. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 sept. 2008

    LRESSP

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    Qui sont les dirigeants de SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EYLES, Melanie
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    Secrétaire
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    British130563500001
    MILLER, Brian Joseph
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    British28463460001
    RICE, Thomas Anthony
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Administrateur
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Irish108501020001
    FULTON, Lesley
    87 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AW Ponteland
    Northumberland
    Secrétaire
    87 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AW Ponteland
    Northumberland
    British89535080001
    HETHERINGTON, Keith
    74a Fulthorpe Avenue
    DL3 9QH Darlington
    County Durham
    Secrétaire
    74a Fulthorpe Avenue
    DL3 9QH Darlington
    County Durham
    British27694690001
    STAPLES, Anthony John
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    Secrétaire
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    British45838190001
    B-R SECRETARIAT LIMITED
    Third Floor
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    Secrétaire
    Third Floor
    4 Millbank
    SW1P 3XR London
    33582140001
    BAILEY, Trevor Howard
    Ampleforth House
    Gilling Close Gilling Road
    DL10 5AY Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    Ampleforth House
    Gilling Close Gilling Road
    DL10 5AY Richmond
    North Yorkshire
    British15206530002
    BROWN, John Keith
    Harvel Cottage 30 Hallatrow Road
    Paulton
    BS39 7LJ Bristol
    Administrateur
    Harvel Cottage 30 Hallatrow Road
    Paulton
    BS39 7LJ Bristol
    EnglandBritish60781220001
    CRAWFORD, Gordon
    29 Barrowburn Place
    Seghill
    NE23 7HA Cramlington
    Tyne & Wear
    Administrateur
    29 Barrowburn Place
    Seghill
    NE23 7HA Cramlington
    Tyne & Wear
    British9846670001
    FULTON, David Maxwell
    The Cottage 87 Western Way
    Ponteland
    NE20 9AW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    The Cottage 87 Western Way
    Ponteland
    NE20 9AW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British29804310001
    FULTON, Lesley
    87 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AW Ponteland
    Northumberland
    Administrateur
    87 Western Way
    Darras Hall
    NE20 9AW Ponteland
    Northumberland
    British89535080001
    HETHERINGTON, Keith
    74a Fulthorpe Avenue
    DL3 9QH Darlington
    County Durham
    Administrateur
    74a Fulthorpe Avenue
    DL3 9QH Darlington
    County Durham
    British27694690001
    HOLDRON, Richard Lancaster
    Weald Cottage
    Hunton
    ME15 0QY Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Weald Cottage
    Hunton
    ME15 0QY Maidstone
    Kent
    British6377350003
    STEAD, David Richard
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish72400470001
    WILLIAMS, John David
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    British74014480001

    SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A credit agreement entitled "prompt credit application"
    Créé le 09 juil. 1993
    Livré le 16 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £26,766.60 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 16 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Corporate mortgage
    Créé le 27 juil. 1990
    Livré le 09 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 11/4/90
    Brèves mentions
    The goods, the benefits of all contracts all log books, record books kirby printer slotter with serial no MP5103 (for full details refer to doc 395 ref M343C).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 1988
    Livré le 28 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at planet place, george stephenson industrial estate, killingworth, tyne & wear with factory office preimses & buildings.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 06 oct. 1988
    Livré le 10 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Crosland automatic cutting and creasing machine type ap 1340/01 no 190/cw.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 mars 1987
    Livré le 07 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory office premises and land at junction of plant place and northumbria way, killingworth, tyne and wear otherwise k/a tritek house.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 1985
    Livré le 13 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 21/12/84
    Brèves mentions
    L/H premises k/a site bt 96/5 at walker industrial estate, newcastle upon tyne, tyne & wear described in a lease dated 21/12/84 (see doc M10).
    Personnes ayant droit
    • English Industrial Estates Corporation
    Transactions
    • 13 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 nov. 1982
    Livré le 16 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book & other debts uncalled capital together with all fixtures (incl trade fixtures) fixed plant & machinery (see doc M9).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SCA PACKAGING TRITEK CARDBOARD PACKAGING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 févr. 2010Dissolved on
    15 sept. 2008Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0