INTER-CITY PAGING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTER-CITY PAGING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01643672
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTER-CITY PAGING LIMITED ?

    • Activités de télécommunications sans fil (61200) / Information et communication

    Où se situe INTER-CITY PAGING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTER-CITY PAGING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    C.I. RADIOPAGING LIMITED24 août 198224 août 1982
    ANVILBEACON LIMITED16 juin 198216 juin 1982

    Quels sont les derniers comptes de INTER-CITY PAGING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour INTER-CITY PAGING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 17 Rochester Row London SW1P 1QT à 1 More London Place London SE1 2AF le 29 mars 2018

    2 pagesAD01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 71 Victoria Street London SW1H 0XA

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 71 Victoria Street London SW1H 0XA

    2 pagesAD02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 mars 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination de Mrs Francesca Anne Todd en tant qu'administrateur le 05 mars 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christopher Francis Henry Baker en tant que directeur le 05 mars 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stefan John Maynard en tant que directeur le 05 mars 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de William Stephen Mcbrinn en tant que directeur le 28 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher Francis Henry Baker en tant qu'administrateur le 14 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Hilton Rodgerson en tant que directeur le 14 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr William Stephen Mcbrinn en tant qu'administrateur le 01 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jamie Leigh Radford en tant que directeur le 01 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2016

    État du capital au 15 avr. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Jamie Leigh Radford en tant qu'administrateur le 03 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Patrick Collier en tant que directeur le 03 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juil. 2015

    État du capital au 21 juil. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2014 au 31 déc. 2014

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de INTER-CITY PAGING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Secrétaire
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish72249980002
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5641516
    129795770003
    ATHERSYCH, Christopher John
    Greenwood St Olives Close
    Cross In Hand
    TN21 0QE Heathfield
    East Sussex
    Secrétaire
    Greenwood St Olives Close
    Cross In Hand
    TN21 0QE Heathfield
    East Sussex
    British78115670001
    CHADWICK, Alan Michael
    96 Warwick Avenue
    HA8 8UJ Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    96 Warwick Avenue
    HA8 8UJ Edgware
    Middlesex
    British16262350001
    DICKINSON, Peter John Goddard
    39 Park Road
    TW11 0AY Teddington
    Middlesex
    Secrétaire
    39 Park Road
    TW11 0AY Teddington
    Middlesex
    British38889200001
    LYELL, Stephen Edward
    39 Egham Road
    Plaistow
    E13 8PD London
    Secrétaire
    39 Egham Road
    Plaistow
    E13 8PD London
    British61928420001
    MEDCALF, Sarah
    Marsh Lane
    Taplow
    SL6 0DE Maidenhead
    Glengarry
    England
    Secrétaire
    Marsh Lane
    Taplow
    SL6 0DE Maidenhead
    Glengarry
    England
    159244830001
    SIMON, Hugh Adams, Mr.
    Chilton Lodge Speen Lane
    RG14 1RN Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Chilton Lodge Speen Lane
    RG14 1RN Newbury
    Berkshire
    British49056950001
    TAYLOR, Michael John
    109 Hallowell Road
    HA6 1DY Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    109 Hallowell Road
    HA6 1DY Northwood
    Middlesex
    British75861690001
    ATTWOOLL, Rodney Philip
    18 Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    18 Prince Consort Drive
    SL5 8AW Ascot
    Berkshire
    British63982200002
    BAKER, Christopher Francis Henry
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish219844020001
    BOTTS, John Chester
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    Administrateur
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    United KingdomAmerican2943960001
    COLLIER, Michael Patrick
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish182710350001
    D'JANOEFF, Alexander Constantine Basil
    Flat 3 Avenue Court
    Draycott Avenue
    SW3 3BU London
    Administrateur
    Flat 3 Avenue Court
    Draycott Avenue
    SW3 3BU London
    British69177260001
    FRAWLEY, Michael
    36 Ampthill Road
    Silsoe
    MK45 4DX Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    36 Ampthill Road
    Silsoe
    MK45 4DX Bedford
    Bedfordshire
    British70921480001
    FUELLHART, Janice
    14 Grosvenor Hill Court
    15 Bourdon Street
    W1K 3PX London
    Administrateur
    14 Grosvenor Hill Court
    15 Bourdon Street
    W1K 3PX London
    Us Citizen49542950007
    FUGATE, John Robert
    1633 Winchester
    MS 39211 Jackson
    Mississippi
    Usa
    Administrateur
    1633 Winchester
    MS 39211 Jackson
    Mississippi
    Usa
    American16262360004
    GOOD, Alexander Hansen
    23 Eastbrooke
    FOREIGN Jackson
    Mississippi 39216
    Usa
    Administrateur
    23 Eastbrooke
    FOREIGN Jackson
    Mississippi 39216
    Usa
    American16821760001
    GRAY, Nigel Martin
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    Administrateur
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    EnglandBritish120162140002
    HARRISON, John Stephen
    1220 Park Avenue
    Apt No 14a
    10128 New York
    Usa
    Administrateur
    1220 Park Avenue
    Apt No 14a
    10128 New York
    Usa
    American49160010001
    HENNING, David
    Chapel Cottage
    Ashford Hill
    RG19 8BG Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    Chapel Cottage
    Ashford Hill
    RG19 8BG Thatcham
    Berkshire
    British71530430001
    JONES, Christopher William
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    Administrateur
    12th Floor Gw1
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Great West House
    Middlesex
    EnglandBritish274714740001
    MAYNARD, Stefan John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish274905000001
    MCBRINN, William Stephen
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish161340530001
    MULADY, Barry James, Dr
    Springbank
    Oldlands Herons Ghyll
    TN22 3DA Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Springbank
    Oldlands Herons Ghyll
    TN22 3DA Uckfield
    East Sussex
    United KingdomBritish13069930001
    NABARRO, Daniel Joseph Nunes
    87 Kingsley Way
    N2 0EL London
    Administrateur
    87 Kingsley Way
    N2 0EL London
    Canadian/British43350470001
    NEARY, Christopher
    22 Pollards Close
    Cheshunt
    EN7 5JP Waltham Cross
    Hertfordshire
    Administrateur
    22 Pollards Close
    Cheshunt
    EN7 5JP Waltham Cross
    Hertfordshire
    British47022960002
    RADFORD, Jamie Leigh
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish193131980001
    READ, James Allan
    Little Adelphi
    Flat No 12 10-14 John Adams Street
    WC2N 68A London
    Administrateur
    Little Adelphi
    Flat No 12 10-14 John Adams Street
    WC2N 68A London
    American32172560003
    REICHER, Andrew William Michael
    60 Croftdown Road
    NW5 1EN London
    Administrateur
    60 Croftdown Road
    NW5 1EN London
    EnglandBritish42421970002
    REISS, Richard
    1001 Park Avenue
    New York Ny10028 New York
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    1001 Park Avenue
    New York Ny10028 New York
    FOREIGN Usa
    Us Citizen49056890001
    REYNOLDS, James Henry
    89 Whiteknights Road
    RG6 2BB Reading
    Berkshire
    Administrateur
    89 Whiteknights Road
    RG6 2BB Reading
    Berkshire
    British68848830001
    RODEN, Mark
    78 Heytesbury Lane
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    78 Heytesbury Lane
    Dublin 4
    Ireland
    Irish68587490001
    RODGERSON, Craig Hilton
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish188334810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTER-CITY PAGING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01991595
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    INTER-CITY PAGING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A fixed and floating security document (the "security document" between the company, certain other chargors as listed in schedule 1 of the security document (together the "chargors") and chase manhattan international limited in its capacity as security agent for the finance parties (the "security agent")
    Créé le 17 nov. 2000
    Livré le 07 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited
    Transactions
    • 07 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite debenture
    Créé le 12 juil. 1996
    Livré le 22 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations of the obligors (as defined) to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) and to the finance parties under the finance documents
    Brèves mentions
    All that l/h and licence property including carlton house salford manchester and derby house merstham surrey with all buildings and fixtures and proceeds of sale please reefer to form 395 and additional pages for full details of charged assets.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Investment Bank Limited
    Transactions
    • 22 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of legal charge
    Créé le 11 oct. 1991
    Livré le 18 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this deed and the various deeds and documents as defined therein
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over all those properties as defined together with all buildings, erections, fixtures, fittings and fixed plant and machinery (see doc M480C for full details).
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bankthe Other Lenders as Defined in the Agreementfor Itself and as Agent for Credit Lyonnais And
    Transactions
    • 18 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 févr. 1991
    Livré le 04 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a debenture and a credit agreement both dated december 11TH 1990. this charge and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over:- a) l/h property at 28, the broadway, darkes lane, potters bar, hertfordshire. B) l/h property of carlton house, eccles new road, salford, manchester. T/n: cm 542741. together with all buildings erections, fixtures, fittings, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bankt) Other Lenders as Defined in the Credit Agreemen(As Agent for Itself and Credit Lyonnais and The
    Transactions
    • 04 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture fixed and floating charge
    Créé le 11 déc. 1990
    Livré le 31 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "fundamental documents" (as defined)
    Brèves mentions
    (See doc M209 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bankthe Other Lenders (As Defined)for Itself and as Agent for Credit Lyonnais And
    Transactions
    • 31 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 02 nov. 1989
    Livré le 13 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 17 juil. 1986
    Livré le 28 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 28 juil. 1986Enregistrement d'une charge

    INTER-CITY PAGING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 mars 2018Commencement of winding up
    10 nov. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0