INTER-CITY PAGING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INTER-CITY PAGING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01643672 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INTER-CITY PAGING LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INTER-CITY PAGING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour INTER-CITY PAGING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 17 Rochester Row London SW1P 1QT à 1 More London Place London SE1 2AF le 29 mars 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 71 Victoria Street London SW1H 0XA | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 71 Victoria Street London SW1H 0XA | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Francesca Anne Todd en tant qu'administrateur le 05 mars 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Francis Henry Baker en tant que directeur le 05 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stefan John Maynard en tant que directeur le 05 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Stephen Mcbrinn en tant que directeur le 28 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Francis Henry Baker en tant qu'administrateur le 14 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Craig Hilton Rodgerson en tant que directeur le 14 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr William Stephen Mcbrinn en tant qu'administrateur le 01 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jamie Leigh Radford en tant que directeur le 01 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Jamie Leigh Radford en tant qu'administrateur le 03 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Patrick Collier en tant que directeur le 03 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2014 au 31 déc. 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INTER-CITY PAGING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom |
| 135207160001 | ||||||||||
| TODD, Francesca Anne | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | 72249980002 | |||||||||
| CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom |
| 129795770003 | ||||||||||
| ATHERSYCH, Christopher John | Secrétaire | Greenwood St Olives Close Cross In Hand TN21 0QE Heathfield East Sussex | British | 78115670001 | ||||||||||
| CHADWICK, Alan Michael | Secrétaire | 96 Warwick Avenue HA8 8UJ Edgware Middlesex | British | 16262350001 | ||||||||||
| DICKINSON, Peter John Goddard | Secrétaire | 39 Park Road TW11 0AY Teddington Middlesex | British | 38889200001 | ||||||||||
| LYELL, Stephen Edward | Secrétaire | 39 Egham Road Plaistow E13 8PD London | British | 61928420001 | ||||||||||
| MEDCALF, Sarah | Secrétaire | Marsh Lane Taplow SL6 0DE Maidenhead Glengarry England | 159244830001 | |||||||||||
| SIMON, Hugh Adams, Mr. | Secrétaire | Chilton Lodge Speen Lane RG14 1RN Newbury Berkshire | British | 49056950001 | ||||||||||
| TAYLOR, Michael John | Secrétaire | 109 Hallowell Road HA6 1DY Northwood Middlesex | British | 75861690001 | ||||||||||
| ATTWOOLL, Rodney Philip | Administrateur | 18 Prince Consort Drive SL5 8AW Ascot Berkshire | British | 63982200002 | ||||||||||
| BAKER, Christopher Francis Henry | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 219844020001 | |||||||||
| BOTTS, John Chester | Administrateur | 21 Argyll Road W8 7DA London | United Kingdom | American | 2943960001 | |||||||||
| COLLIER, Michael Patrick | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 182710350001 | |||||||||
| D'JANOEFF, Alexander Constantine Basil | Administrateur | Flat 3 Avenue Court Draycott Avenue SW3 3BU London | British | 69177260001 | ||||||||||
| FRAWLEY, Michael | Administrateur | 36 Ampthill Road Silsoe MK45 4DX Bedford Bedfordshire | British | 70921480001 | ||||||||||
| FUELLHART, Janice | Administrateur | 14 Grosvenor Hill Court 15 Bourdon Street W1K 3PX London | Us Citizen | 49542950007 | ||||||||||
| FUGATE, John Robert | Administrateur | 1633 Winchester MS 39211 Jackson Mississippi Usa | American | 16262360004 | ||||||||||
| GOOD, Alexander Hansen | Administrateur | 23 Eastbrooke FOREIGN Jackson Mississippi 39216 Usa | American | 16821760001 | ||||||||||
| GRAY, Nigel Martin | Administrateur | 12th Floor Gw1 Great West Road TW8 9DF Brentford Great West House Middlesex | England | British | 120162140002 | |||||||||
| HARRISON, John Stephen | Administrateur | 1220 Park Avenue Apt No 14a 10128 New York Usa | American | 49160010001 | ||||||||||
| HENNING, David | Administrateur | Chapel Cottage Ashford Hill RG19 8BG Thatcham Berkshire | British | 71530430001 | ||||||||||
| JONES, Christopher William | Administrateur | 12th Floor Gw1 Great West Road TW8 9DF Brentford Great West House Middlesex | England | British | 274714740001 | |||||||||
| MAYNARD, Stefan John | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 274905000001 | |||||||||
| MCBRINN, William Stephen | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 161340530001 | |||||||||
| MULADY, Barry James, Dr | Administrateur | Springbank Oldlands Herons Ghyll TN22 3DA Uckfield East Sussex | United Kingdom | British | 13069930001 | |||||||||
| NABARRO, Daniel Joseph Nunes | Administrateur | 87 Kingsley Way N2 0EL London | Canadian/British | 43350470001 | ||||||||||
| NEARY, Christopher | Administrateur | 22 Pollards Close Cheshunt EN7 5JP Waltham Cross Hertfordshire | British | 47022960002 | ||||||||||
| RADFORD, Jamie Leigh | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | 193131980001 | |||||||||
| READ, James Allan | Administrateur | Little Adelphi Flat No 12 10-14 John Adams Street WC2N 68A London | American | 32172560003 | ||||||||||
| REICHER, Andrew William Michael | Administrateur | 60 Croftdown Road NW5 1EN London | England | British | 42421970002 | |||||||||
| REISS, Richard | Administrateur | 1001 Park Avenue New York Ny10028 New York FOREIGN Usa | Us Citizen | 49056890001 | ||||||||||
| REYNOLDS, James Henry | Administrateur | 89 Whiteknights Road RG6 2BB Reading Berkshire | British | 68848830001 | ||||||||||
| RODEN, Mark | Administrateur | 78 Heytesbury Lane Dublin 4 Ireland | Irish | 68587490001 | ||||||||||
| RODGERSON, Craig Hilton | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 188334810001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTER-CITY PAGING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentside Communications Limited | 06 avr. 2016 | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
INTER-CITY PAGING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A fixed and floating security document (the "security document" between the company, certain other chargors as listed in schedule 1 of the security document (together the "chargors") and chase manhattan international limited in its capacity as security agent for the finance parties (the "security agent") | Créé le 17 nov. 2000 Livré le 07 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 12 juil. 1996 Livré le 22 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations of the obligors (as defined) to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) and to the finance parties under the finance documents | |
Brèves mentions All that l/h and licence property including carlton house salford manchester and derby house merstham surrey with all buildings and fixtures and proceeds of sale please reefer to form 395 and additional pages for full details of charged assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of legal charge | Créé le 11 oct. 1991 Livré le 18 oct. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this deed and the various deeds and documents as defined therein | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all those properties as defined together with all buildings, erections, fixtures, fittings and fixed plant and machinery (see doc M480C for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 15 févr. 1991 Livré le 04 mars 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under a debenture and a credit agreement both dated december 11TH 1990. this charge and deeds supplemental thereto. | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over:- a) l/h property at 28, the broadway, darkes lane, potters bar, hertfordshire. B) l/h property of carlton house, eccles new road, salford, manchester. T/n: cm 542741. together with all buildings erections, fixtures, fittings, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture fixed and floating charge | Créé le 11 déc. 1990 Livré le 31 déc. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "fundamental documents" (as defined) | |
Brèves mentions (See doc M209 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 02 nov. 1989 Livré le 13 nov. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 17 juil. 1986 Livré le 28 juil. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
INTER-CITY PAGING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0