SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED

SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01648234
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Philips Centre
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Surrey
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PHILIPS CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED28 févr. 200828 févr. 2008
    MASSIVE UK LIMITED22 déc. 198222 déc. 1982
    DARKAIRN LIMITED05 juil. 198205 juil. 1982

    Quels sont les derniers comptes de SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Rob Yozef Lambertus De Weert en tant qu'administrateur le 02 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andre Secrest en tant que directeur le 27 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Massive Holding Uk Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 avr. 2018

    1 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 11 avr. 2018

    2 pagesPSC09

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name15 mars 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Mr Andre Secrest en tant qu'administrateur le 13 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Prem Waran en tant que directeur le 13 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 juin 2016

    État du capital au 02 juin 2016

    • Capital: GBP 3,800,000
    SH01

    Nomination de Mr Prem Waran en tant qu'administrateur le 01 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Lynn Margaret Millns en tant qu'administrateur le 01 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Lynn Margaret Millns en tant que secrétaire le 01 févr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Graham Tranter en tant que directeur le 01 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martin Robert Armstrong en tant que secrétaire le 01 févr. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Martin Robert Armstrong en tant que directeur le 01 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Philips Centre Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XH à Philips Centre Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XG le 19 janv. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Graham Tranter en tant qu'administrateur le 31 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Hayden Paul Vivash en tant que directeur le 15 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MILLNS, Lynn Margaret
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Secrétaire
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    204837080001
    DE WEERT, Rob Jozef Lambertus
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    EnglandDutchFinancial Controller251035120001
    MILLNS, Lynn Margaret
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    EnglandIrishLawyer204804580001
    ADRIAENS, Redgy Roland Marie
    Paalsteen 4
    Sint Martens Latem
    FOREIGN 9830 Belgium
    Secrétaire
    Paalsteen 4
    Sint Martens Latem
    FOREIGN 9830 Belgium
    BelgianCompany Director47488820002
    ARMSTRONG, Martin Robert
    46 Ingram Road
    CR7 8EB Thornton Heath
    Surrey
    Secrétaire
    46 Ingram Road
    CR7 8EB Thornton Heath
    Surrey
    British81604920002
    DE JAECK, Edouard
    Satenrozen 13
    FOREIGN 2550 Kontich
    Belgium
    Secrétaire
    Satenrozen 13
    FOREIGN 2550 Kontich
    Belgium
    Belgium10886480001
    DE NAEYER, Ghislain
    38 Vandepeerebroomlaan
    Kortrijk 8500
    FOREIGN Belgium
    Secrétaire
    38 Vandepeerebroomlaan
    Kortrijk 8500
    FOREIGN Belgium
    BelgianCompany Director50577770001
    NATLEY, Robin Lewis
    Plantation House
    The Street Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    Secrétaire
    Plantation House
    The Street Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    BritishCompany Director88608640001
    ADRIAENS, Redgy Roland Marie
    Paalsteen 4
    Sint Martens Latem
    FOREIGN 9830 Belgium
    Administrateur
    Paalsteen 4
    Sint Martens Latem
    FOREIGN 9830 Belgium
    BelgianCompany Director47488820002
    ARMSTRONG, Martin Robert
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    EnglandBritishBarrister81604920002
    BIJLSMA, Allard All
    Torenlaan 58 125ihl
    Laren
    Netherlands Antilles
    Administrateur
    Torenlaan 58 125ihl
    Laren
    Netherlands Antilles
    DutchChief Executive Officer128871730001
    DE JAECK, Edouard
    Satenrozen 13
    FOREIGN 2550 Kontich
    Belgium
    Administrateur
    Satenrozen 13
    FOREIGN 2550 Kontich
    Belgium
    BelgiumCompany Director10886480001
    DE JAECK, Jan Margaretha Roger
    Nerenaard 3
    B2550 Kontich
    Belgium
    Administrateur
    Nerenaard 3
    B2550 Kontich
    Belgium
    BelgianDirector59232640001
    DE JAECK, Petrus Anna Carolus
    Waarloosveld 46
    Kontich 2550
    FOREIGN Belgium
    Administrateur
    Waarloosveld 46
    Kontich 2550
    FOREIGN Belgium
    BelgiumCompany Director10886490002
    DE NAEYER, Ghislain
    38 Vandepeerebroomlaan
    Kortrijk 8500
    FOREIGN Belgium
    Administrateur
    38 Vandepeerebroomlaan
    Kortrijk 8500
    FOREIGN Belgium
    BelgianCompany Director50577770001
    HUGHES, David Stewart
    105 Woodland Drive
    BN3 6DF Hove
    East Sussex
    Administrateur
    105 Woodland Drive
    BN3 6DF Hove
    East Sussex
    EnglandBritishGeneral Manager33205940001
    MASKELL, Peter John
    43 Foley Road
    Claygate
    KT10 0LU Esher
    Surrey
    Administrateur
    43 Foley Road
    Claygate
    KT10 0LU Esher
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director Chairman36222380001
    MERMANS, Sven
    A. Reydamslaan 38
    Mol
    2400
    Belgium
    Administrateur
    A. Reydamslaan 38
    Mol
    2400
    Belgium
    BelgianDirector116630200001
    NATLEY, Robin Lewis
    Plantation House
    The Street Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    Administrateur
    Plantation House
    The Street Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director88608640001
    NOTEN, Jules
    Zegersdreef 3
    Brasschaat
    B-2930
    Belgium
    Administrateur
    Zegersdreef 3
    Brasschaat
    B-2930
    Belgium
    BelgiumNone100456890001
    RUINEMANS, Jan Willem
    Frankrijkel 88 2000
    Antwerpen
    Belgium
    Administrateur
    Frankrijkel 88 2000
    Antwerpen
    Belgium
    DutchChief Financial Officer128871950001
    SECREST, Andre
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    NetherlandsDutchChief Financial Officer (Cfo)238030150001
    TRANTER, Graham
    Guildford Business Park
    GU2 8XH Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XH Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    United KingdomBritishHead Of Finance203691280001
    TRANTER, Graham
    HA4
    Administrateur
    HA4
    United KingdomBritishGroup Financial Director110536940001
    VEYSEY, Mark
    South Beach
    2 Foxholes Hill
    EX8 2DF Exmouth
    Devon
    Administrateur
    South Beach
    2 Foxholes Hill
    EX8 2DF Exmouth
    Devon
    BritishCompany Director116288090001
    VIVASH, Hayden Paul
    Guildford Business Park
    GU2 8XH Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XH Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    EnglandBritishGroup Cfo146515590001
    WARAN, Prem
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    Surrey
    England
    United KingdomBritishHead Of Finance204803870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Massive Holding Uk Ltd
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    England
    11 avr. 2018
    Guildford Business Park
    GU2 8XG Guildford
    Philips Centre
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleEnglish Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    01 juin 201710 avr. 2018La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge on debts
    Créé le 26 janv. 2006
    Livré le 28 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any debt of which ownership fails to vest all amounts of indebtedness floating charge the specified debts, the other debts and the companys account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 28 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2005
    Livré le 21 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security agent or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the accounts, goodwill uncalled capital investments, monetary claims, floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V.
    Transactions
    • 21 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 2002
    Livré le 18 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all of the company's right, title and interest to the accounts, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments and the monetary claims. By way of floating charge all the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Bank N.V. as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 18 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 25 févr. 1999
    Livré le 04 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 oct. 1992
    Livré le 13 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage.
    Créé le 01 oct. 1992
    Livré le 13 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west of castle road,sittingbourne swale,kent , and the proceeds of sale thereof. Title no k 670824. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC.
    Transactions
    • 13 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0