SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01648234 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?
Adresse du siège social | Philips Centre Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Surrey England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Rob Yozef Lambertus De Weert en tant qu'administrateur le 02 oct. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andre Secrest en tant que directeur le 27 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Massive Holding Uk Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 avr. 2018 | 1 pages | PSC02 | ||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 11 avr. 2018 | 2 pages | PSC09 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Andre Secrest en tant qu'administrateur le 13 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Prem Waran en tant que directeur le 13 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Prem Waran en tant qu'administrateur le 01 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Lynn Margaret Millns en tant qu'administrateur le 01 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Lynn Margaret Millns en tant que secrétaire le 01 févr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Tranter en tant que directeur le 01 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Robert Armstrong en tant que secrétaire le 01 févr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Robert Armstrong en tant que directeur le 01 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Philips Centre Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XH à Philips Centre Guildford Business Park Guildford Surrey GU2 8XG le 19 janv. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Graham Tranter en tant qu'administrateur le 31 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hayden Paul Vivash en tant que directeur le 15 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILLNS, Lynn Margaret | Secrétaire | Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Philips Centre Surrey England | 204837080001 | |||||||
DE WEERT, Rob Jozef Lambertus | Administrateur | Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Philips Centre Surrey England | England | Dutch | Financial Controller | 251035120001 | ||||
MILLNS, Lynn Margaret | Administrateur | Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Philips Centre Surrey England | England | Irish | Lawyer | 204804580001 | ||||
ADRIAENS, Redgy Roland Marie | Secrétaire | Paalsteen 4 Sint Martens Latem FOREIGN 9830 Belgium | Belgian | Company Director | 47488820002 | |||||
ARMSTRONG, Martin Robert | Secrétaire | 46 Ingram Road CR7 8EB Thornton Heath Surrey | British | 81604920002 | ||||||
DE JAECK, Edouard | Secrétaire | Satenrozen 13 FOREIGN 2550 Kontich Belgium | Belgium | 10886480001 | ||||||
DE NAEYER, Ghislain | Secrétaire | 38 Vandepeerebroomlaan Kortrijk 8500 FOREIGN Belgium | Belgian | Company Director | 50577770001 | |||||
NATLEY, Robin Lewis | Secrétaire | Plantation House The Street Eastling ME13 0AZ Faversham Kent | British | Company Director | 88608640001 | |||||
ADRIAENS, Redgy Roland Marie | Administrateur | Paalsteen 4 Sint Martens Latem FOREIGN 9830 Belgium | Belgian | Company Director | 47488820002 | |||||
ARMSTRONG, Martin Robert | Administrateur | Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Philips Centre Surrey England | England | British | Barrister | 81604920002 | ||||
BIJLSMA, Allard All | Administrateur | Torenlaan 58 125ihl Laren Netherlands Antilles | Dutch | Chief Executive Officer | 128871730001 | |||||
DE JAECK, Edouard | Administrateur | Satenrozen 13 FOREIGN 2550 Kontich Belgium | Belgium | Company Director | 10886480001 | |||||
DE JAECK, Jan Margaretha Roger | Administrateur | Nerenaard 3 B2550 Kontich Belgium | Belgian | Director | 59232640001 | |||||
DE JAECK, Petrus Anna Carolus | Administrateur | Waarloosveld 46 Kontich 2550 FOREIGN Belgium | Belgium | Company Director | 10886490002 | |||||
DE NAEYER, Ghislain | Administrateur | 38 Vandepeerebroomlaan Kortrijk 8500 FOREIGN Belgium | Belgian | Company Director | 50577770001 | |||||
HUGHES, David Stewart | Administrateur | 105 Woodland Drive BN3 6DF Hove East Sussex | England | British | General Manager | 33205940001 | ||||
MASKELL, Peter John | Administrateur | 43 Foley Road Claygate KT10 0LU Esher Surrey | England | British | Managing Director Chairman | 36222380001 | ||||
MERMANS, Sven | Administrateur | A. Reydamslaan 38 Mol 2400 Belgium | Belgian | Director | 116630200001 | |||||
NATLEY, Robin Lewis | Administrateur | Plantation House The Street Eastling ME13 0AZ Faversham Kent | United Kingdom | British | Company Director | 88608640001 | ||||
NOTEN, Jules | Administrateur | Zegersdreef 3 Brasschaat B-2930 Belgium | Belgium | None | 100456890001 | |||||
RUINEMANS, Jan Willem | Administrateur | Frankrijkel 88 2000 Antwerpen Belgium | Dutch | Chief Financial Officer | 128871950001 | |||||
SECREST, Andre | Administrateur | Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Philips Centre Surrey England | Netherlands | Dutch | Chief Financial Officer (Cfo) | 238030150001 | ||||
TRANTER, Graham | Administrateur | Guildford Business Park GU2 8XH Guildford Philips Centre Surrey England | United Kingdom | British | Head Of Finance | 203691280001 | ||||
TRANTER, Graham | Administrateur | HA4 | United Kingdom | British | Group Financial Director | 110536940001 | ||||
VEYSEY, Mark | Administrateur | South Beach 2 Foxholes Hill EX8 2DF Exmouth Devon | British | Company Director | 116288090001 | |||||
VIVASH, Hayden Paul | Administrateur | Guildford Business Park GU2 8XH Guildford Philips Centre Surrey | England | British | Group Cfo | 146515590001 | ||||
WARAN, Prem | Administrateur | Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Philips Centre Surrey England | United Kingdom | British | Head Of Finance | 204803870001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massive Holding Uk Ltd | 11 avr. 2018 | Guildford Business Park GU2 8XG Guildford Philips Centre England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières d éclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
01 juin 2017 | 10 avr. 2018 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
SIGNIFY CONSUMER LUMINAIRES UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge on debts | Créé le 26 janv. 2006 Livré le 28 janv. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any debt of which ownership fails to vest all amounts of indebtedness floating charge the specified debts, the other debts and the companys account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 juil. 2005 Livré le 21 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security agent or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All right title and interest in the accounts, goodwill uncalled capital investments, monetary claims, floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 juil. 2002 Livré le 18 juil. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all of the company's right, title and interest to the accounts, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments and the monetary claims. By way of floating charge all the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture deed | Créé le 25 févr. 1999 Livré le 04 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 01 oct. 1992 Livré le 13 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage. | Créé le 01 oct. 1992 Livré le 13 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land on the north west of castle road,sittingbourne swale,kent , and the proceeds of sale thereof. Title no k 670824. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0