COFFEE POINT (NORTH) LIMITED

COFFEE POINT (NORTH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOFFEE POINT (NORTH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01654243
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COFFEE POINT (NORTH) LIMITED ?

    • Autres services de restauration (56290) / Hébergement et restauration

    Où se situe COFFEE POINT (NORTH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COFFEE POINT (NORTH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BORDER VENDING GROUP PLC18 août 200318 août 2003
    BORDER VENDING & CATERING LTD.17 sept. 198517 sept. 1985
    BORDER VENDING AND CATERING SUPPLIES LIMITED27 juil. 198227 juil. 1982

    Quels sont les derniers comptes de COFFEE POINT (NORTH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 mars 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COFFEE POINT (NORTH) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour COFFEE POINT (NORTH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 02 févr. 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 janv. 2015

    État du capital au 16 janv. 2015

    • Capital: GBP 48,800
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Speechly Bircham Llp 6 New Street Square London EC4A 3LX England à C/O Charles Russell Speechlys Llp 6 New Street Square London EC4A 3LX

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Brian Robert Mackie en tant que directeur le 18 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kris Paul Ludo Geysels en tant qu'administrateur le 18 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 mars 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 janv. 2014

    État du capital au 14 janv. 2014

    • Capital: GBP 48,800
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Brian Mackie le 01 mai 2013

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr Daniel Henry Abrahams en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Helen Willis en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de War Tin en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 avr. 2012

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Greenwood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs War War Tin en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michael Greenwood en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Helen Margaret Willis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Roe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de COFFEE POINT (NORTH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    EnglandBritishChartered Accountant183822370001
    GEYSELS, Kris Paul Ludo
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    BelgiumBelgianDirector193655140001
    BLACKLOCK, Gordon H
    Croft House Farm Whitrigglees
    Kirkbride
    CA5 5EQ Carlisle
    Cumbria
    Secrétaire
    Croft House Farm Whitrigglees
    Kirkbride
    CA5 5EQ Carlisle
    Cumbria
    British1923880001
    BLACKLOCK, Kathleen Mary
    Croft House Whitrigglees
    Kirkbride
    CA5 5EQ Carlisle
    Cumbria
    Secrétaire
    Croft House Whitrigglees
    Kirkbride
    CA5 5EQ Carlisle
    Cumbria
    British34623120001
    GREENWOOD, Michael Frank
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Secrétaire
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    British163172040001
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secrétaire
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    NEWBERRY, Charles Timothy
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Secrétaire
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglishDirector29754260005
    TIN, War War
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Secrétaire
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    174468770001
    BELL, John
    4 Nigel Rise
    Dedridge
    EH54 6LT Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    4 Nigel Rise
    Dedridge
    EH54 6LT Livingston
    West Lothian
    BritishDirector94269030001
    BLACKLOCK, Gordon H
    Croft House Farm Whitrigglees
    Kirkbride
    CA5 5EQ Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Croft House Farm Whitrigglees
    Kirkbride
    CA5 5EQ Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Director1923880001
    BLACKLOCK, Keith
    Yew Tree House
    Thursby
    CA5 6PG Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Yew Tree House
    Thursby
    CA5 6PG Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Director1923890002
    BROTHERWOOD, Tony James
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    Administrateur
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    EnglandBritishCompany Director143546010001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Administrateur
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    United KingdomBritishDirector51864840002
    DOBBS, Neil Stoker
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    Administrateur
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    United KingdomBritishDirector20511010001
    DRYSDALE, Harold Bruce
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    Administrateur
    Field House
    Eachwick
    NE18 0AY Newcastle
    United KingdomBritishCompany Director106272340001
    HAMMOND, Paul Walter
    21 Priorwood Close
    CA2 7TU Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    21 Priorwood Close
    CA2 7TU Carlisle
    Cumbria
    BritishCompany Director23076470001
    MACKIE, Brian Robert
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    ScotlandBritishDirector173446330002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector34345860002
    MURRELL, Andrew John
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    Administrateur
    5 Wood Ride
    BR5 1PZ Petts Wood
    Kent
    EnglandBritishCompany Director114514100001
    NAISMITH, Nicholas John Ewen
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    Administrateur
    Grants
    Grants Lane
    RH8 0RQ Limpsfield
    Surrey
    BritishChief Executive Officer2892470011
    NEWBERRY, Charles Timothy
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Administrateur
    56 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglandEnglishDirector29754260005
    ROE, Timothy Michael
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritishCompany Director51264250001
    STUBBS, Michael David
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    BritishCompany Director146079350001
    WHITELING, Mark Argent
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritishNone101297630001
    WILLIS, Helen Margaret
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Administrateur
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    United KingdomBritishDirector277089380001

    COFFEE POINT (NORTH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 28 sept. 2004
    Livré le 07 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 73 kingstown broadway, kingstown industrial estate, carlisl. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 07 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juin 2003
    Livré le 27 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 27 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mars 2003
    Livré le 28 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 28 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 févr. 2003
    Livré le 13 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 13 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 avr. 1993
    Livré le 11 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at whitrigglees kirkbride cumbria.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 1992
    Livré le 09 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 ridsdale close wallsend tyne and weart/n ty 68284 & ty 205195.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 mars 1986
    Livré le 18 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises situate at hadrians road, wallsend in the county oftyne and wear being po box no 2 NE28 6NB t/n - ty 168968.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1986Enregistrement d'une charge
    • 06 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 12 août 1983
    Livré le 19 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H site no 73 at the kingstown industrial estate, carlisle, cumbria.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1983Enregistrement d'une charge
    • 06 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COFFEE POINT (NORTH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 févr. 2015Commencement of winding up
    22 mars 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0