COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE)
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 01654318 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) ?
| Adresse du siège social | 1 Knights Court Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 29 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2025 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Donald Metcalfe en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Albert Stephenson en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Thomas Richard Harold Sanders en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Stephanie Jane Wharton en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alan John Williams en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Steven John Llewelyn en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Michael Salt en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Edwin Leeding en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Michael John Llewellyn en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Martin William Lane en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Ben Kay en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Carl Paul Ford en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Linda Davies en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Phillip John Davies en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Ian Davies en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Leslie John Bell en tant que directeur le 14 nov. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Michelle Wesley en tant que directeur le 05 févr. 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC08 | ||
Cessation de Alan John Williams en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Paul Anthony Williams en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Steve Whitefoot en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Derek Whitefoot en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Andrew Neville Wild en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 nov. 2025 | 1 pages | PSC07 | ||
Qui sont les dirigeants de COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALL, Robert Phillip | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | United Kingdom | British | 156706240001 | |||||
| GODDARD, Edward Wyatt | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | United Kingdom | British | 85669590001 | |||||
| MILNS, Ken | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 87185390002 | |||||
| ONIONS, Nicholas Charles | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 183964720003 | |||||
| WHITEFOOT, Derek | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 33908930004 | |||||
| WHITEFOOT, Steve | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | Wales | British | 126636540002 | |||||
| WILD, Andrew Neville | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 163291770003 | |||||
| WILLIAMS, Paul Anthony | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 61838030001 | |||||
| ASTBURY, Margaret Susan | Secrétaire | Column House, London Road Shrewsbury SY2 6NN Shropshire | 221857320001 | |||||||
| BOUGHEY, Patrick John | Secrétaire | Mary Rose Cottage 1 Shipton TF13 6JY Much Wenlock Salop | British | 33908900001 | ||||||
| KEY, Margaret Ann | Secrétaire | 5 Ashford Close Pontesbury SY5 0QS Shrewsbury Salop | British | 122304800001 | ||||||
| VAUGHAN, Caroline Alison | Secrétaire | 35 Ludlow Road SY6 6AB Church Stretton Salop | British | 45611030001 | ||||||
| BELL, Leslie John | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 194063830003 | |||||
| BISHOP, Mark Roger | Administrateur | Sibdon SY7 9AG Craven Arms 2 Shropshire England | England | British | 194064400001 | |||||
| BOUGHEY, Neil Richard | Administrateur | 1 Rock Cottage Shipton TF13 6LB Much Wenlock Shropshire | United Kingdom | British | 37974720003 | |||||
| BOUGHEY, Patrick John | Administrateur | Mary Rose Cottage 1 Shipton TF13 6JY Much Wenlock Salop | British | 33908900001 | ||||||
| BUDDEN, Robert | Administrateur | 66 Kendal Road Harlescott SY1 4ES Shrewsbury Shropshire | British | 33909010001 | ||||||
| COOK, James | Administrateur | Bradden Bridge, Shorthill, Lea Cross SY5 8JE Shrewsbury Salop | British | 33908950002 | ||||||
| COOK, Joan | Administrateur | Braddon Bridge, Shorthill Lea Cross SY5 8JE Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 86793790001 | |||||
| DAVIES, Alan Peter | Administrateur | Villas Cottage, Hope, Leighton SY21 8HF Welshpool Powys | Wales | English | 70315870001 | |||||
| DAVIES, Ian | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 221857640001 | |||||
| DAVIES, Linda | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 221857090001 | |||||
| DAVIES, Phillip John | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 135112950002 | |||||
| DUNN, Peter John | Administrateur | 94 Haybridge Road Hadley TF1 4JL Telford Salop | British | 33908980002 | ||||||
| FAULKNER, Brian Ross | Administrateur | 171 Watling Street SY6 Church Stretton Shropshire | British | 33908970001 | ||||||
| FORD, Carl Paul | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | United Kingdom | British | 298710420001 | |||||
| GODDARD, Andrew | Administrateur | 102 Longden Coleham SY3 7DX Shrewsbury Salop | British | 68351730001 | ||||||
| GWILLIAM, Robert James | Administrateur | Emstrey House Shrewsbury Business Park SY2 6GL Shrewsbury Caerwyn Jones Chartered Accountants Shropshire England | England | British | 102286450001 | |||||
| HENDERSON, Thomas | Administrateur | The Plantation Brilley HR3 6ES Whitney On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | 13633100001 | |||||
| KAY, Ben | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 205149100001 | |||||
| KEY, David | Administrateur | 2 Ashford Close Pontesbury SY5 0QS Shrewsbury Salop | England | British | 33908940002 | |||||
| LANE, Martin William | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 194064170003 | |||||
| LEEDING, Anthony Edwin | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | United Kingdom | British | 147182680001 | |||||
| LLEWELLYN, Michael John | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | England | British | 102286400002 | |||||
| LLEWELYN, Steven John | Administrateur | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | United Kingdom | British | 253891370001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Leslie John Bell | 06 avr. 2016 | The Parks SY1 4TJ Shrewsbury 3 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Mark Roger Bishop | 06 avr. 2016 | Sibdon SY7 9AG Craven Arms 2 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Linda Davies | 06 avr. 2016 | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Phillip John Davies | 06 avr. 2016 | Meadowbout Way Bowbrook SY5 8QB Shrewsbury 39 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Edward Wyatt Goddard | 06 avr. 2016 | Shrawardine SY4 1AJ Shrewsbury The Old Post Office Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Robert James Gwilliam | 06 avr. 2016 | Pound Close SY9 5DJ Bishops Castle 2 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Ben Kay | 06 avr. 2016 | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Martin William Lane | 06 avr. 2016 | Brandywell Road TF12 5ST Broseley 16 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Anthony Edwin Leeding | 06 avr. 2016 | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Michael John Llewellyn | 06 avr. 2016 | Chavel Ford SY5 9LB Shrewsbury Fairview Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Bryan Samuel Meredith | 06 avr. 2016 | Westbury Road Heath Farm SY1 3HG Shrewsbury 23 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Donald Metcalfe | 06 avr. 2016 | Ryelands SY3 9BZ Shrewsbury 7 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Ken Milns | 06 avr. 2016 | Boughey Road TF10 7QF Newport 27 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Nicholas Charles Onions | 06 avr. 2016 | Pleasant View, Aston Pigott Westbury SY5 9HJ Shrewsbury 20 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Wilfred David Onions | 06 avr. 2016 | Hereford Road SY3 0EF Shrewsbury Laneside Burgs Lane Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Michael Salt | 06 avr. 2016 | Noneley SY4 5SL Wem Shayes Farm Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Thomas Richard Harold Sanders | 06 avr. 2016 | St. Johns Walk Lawley Village TF4 2FT Telford 28 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Derek Whitefoot | 06 avr. 2016 | Brooklands Park SY7 9RL Craven Arms 40 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Steve Whitefoot | 06 avr. 2016 | Burgess Close SY21 7QZ Welshpool 1 Powys Wales | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Wales | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Andrew Neville Wild | 06 avr. 2016 | Moss Lane Bramhall SK7 1BG Stockport 175 Cheshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Alan John Williams | 06 avr. 2016 | Archers Way Battlefield Enterprise Park SY1 3GA Shrewsbury 1 Knights Court England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Paul Anthony Williams | 06 avr. 2016 | Brightwell Reabrook SY3 7TQ Shrewsbury 27 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Tony Seddon | 06 avr. 2016 | Fenns Bank Bronnington SY13 3PE Whitchurch The View Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr David Key | 06 avr. 2016 | Ashford Close Pontesbury SY5 0QS Shrewsbury 2 Shropshire England | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour COUNTY OF SALOP STEAM ENGINE SOCIETY LIMITED(THE) ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 03 nov. 2025 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0