TAB WALES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTAB WALES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01656239
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TAB WALES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TAB WALES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Blaenwaun, Ffostrasol
    Llandysul
    SA44 5JT Ceredigion
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TAB WALES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THERAPEUTIC ANTIBODIES LIMITED02 sept. 198302 sept. 1983
    SARIA LIMITED03 août 198203 août 1982

    Quels sont les derniers comptes de TAB WALES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TAB WALES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2013

    État du capital au 02 janv. 2013

    • Capital: GBP 8,132,319
    SH01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 nov. 2012

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Peter Geoffrey Maddox en tant que secrétaire le 15 févr. 2012

    1 pagesTM02

    Nomination de Lygia Jane Jones en tant que secrétaire le 15 févr. 2012

    1 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de James Christie en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de James Christie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Peter Geoffrey Maddox le 31 déc. 2010

    2 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Campbell Christie le 31 déc. 2009

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées du secrétaire Peter Geoffrey Maddox le 31 déc. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de TAB WALES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Lygia Jane
    Blaenwaun, Ffostrasol
    Llandysul
    SA44 5JT Ceredigion
    Secrétaire
    Blaenwaun, Ffostrasol
    Llandysul
    SA44 5JT Ceredigion
    166927550001
    MAKIN, Pamela Louise, Dame
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Administrateur
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    EnglandBritish111491920002
    SODERSTROM, Rolf Kristian Berndtson
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Administrateur
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    EnglandBritish123922800005
    CHARD, Timothy, Professor
    509 Mountjoy House
    EC2Y 8BP London
    Secrétaire
    509 Mountjoy House
    EC2Y 8BP London
    English24354460001
    COLLIER, Paul Robert
    Llanfallteg Farm
    Llanfallteg
    SA34 0UP Whitland
    Carmarthenshire
    Secrétaire
    Llanfallteg Farm
    Llanfallteg
    SA34 0UP Whitland
    Carmarthenshire
    British58105660001
    HAMBLIN, Michael Alan John William
    Lower Farm West Ginge
    Ardington
    OX12 8QR Wantage
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Lower Farm West Ginge
    Ardington
    OX12 8QR Wantage
    Oxfordshire
    British37951310002
    MADDOX, Peter Geoffrey
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    British53027030001
    VICKERS, Julie Alison
    57 White Park Close
    CW10 9GB Middlewich
    Cheshire
    Secrétaire
    57 White Park Close
    CW10 9GB Middlewich
    Cheshire
    British71031050003
    BROWNE, Harry Gray, Dr
    4626 Columbia Highway
    FOREIGN Thompson Station
    Tennessee 37179
    Usa
    Administrateur
    4626 Columbia Highway
    FOREIGN Thompson Station
    Tennessee 37179
    Usa
    Us31059280001
    CHARD, Timothy
    171 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Administrateur
    171 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    English24354460002
    CHRISTIE, James Campbell
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Btg Plc
    Fleet Place
    EC4M 7RD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish63090380001
    HEATH, Andrew John William, Dr
    Flat 2
    24 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    Administrateur
    Flat 2
    24 Sloane Gardens
    SW1W 8DJ London
    United KingdomBritish66554500005
    KAZIMI, Aj
    712 Overton Park
    FOREIGN Nashville
    Tennessee 37215
    Usa
    Administrateur
    712 Overton Park
    FOREIGN Nashville
    Tennessee 37215
    Usa
    Us31059270001
    LANDON, John, Professor
    535 Willoughby House
    EC2Y 8BN London
    Administrateur
    535 Willoughby House
    EC2Y 8BN London
    British14699440001
    REES, David Ian
    Cae Nos
    Ffostrasol
    SA44 5JT Llandysul
    Dyfed
    Administrateur
    Cae Nos
    Ffostrasol
    SA44 5JT Llandysul
    Dyfed
    British59818880001
    SODEN, Christine Helen
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    Administrateur
    5 Fleet Place
    EC4M 7RD London
    Btg Plc
    British65904960008

    TAB WALES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Sublease agreement
    Créé le 14 déc. 1995
    Livré le 19 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Brèves mentions
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 009 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transactions
    • 19 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sublease agreement
    Créé le 27 oct. 1995
    Livré le 19 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Brèves mentions
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 008 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transactions
    • 19 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 25 oct. 1995
    Livré le 03 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from therapeutic antibodies inc to the chargee under the terms of a promissory note dated 24TH july 1995, an amended and restated promissory note and loan agreement both dated 25TH october 1995 and/or in connection with this supplemental debenture
    Brèves mentions
    By way of floating charge all book debts owing to the company and all stock and work in progress (including all stocks of anti sera) the property of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Equitas, L.P.
    Transactions
    • 03 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 1995
    Livré le 04 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from therapeutic antibodies inc to the chargee under the terms of a promissory note of even date and a guarantee (as defined)
    Brèves mentions
    Floating charge over all book debts owing to the company and all stock and work in progress. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Equitas L.P.
    Transactions
    • 04 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Intellectual property mortgage
    Créé le 03 mai 1995
    Livré le 23 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a secured loan agreement dated 3RD may 1995 and the mortgage as defined therein
    Brèves mentions
    All the intellectual property including UK patent number 2271509B entitled "an venom immunesera" together with the full benefit of all rights and know-how. All trade marks and a floating charge over all rights and interests in the property,assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Welsh Development Agency(The "Agency")
    Transactions
    • 23 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sublease agreement
    Créé le 10 avr. 1995
    Livré le 19 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Brèves mentions
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease agreement and acceptance certificate no 007 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transactions
    • 19 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sublease agreement
    Créé le 30 janv. 1995
    Livré le 19 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Brèves mentions
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 006 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transactions
    • 19 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sublease agreement
    Créé le 07 déc. 1994
    Livré le 19 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Brèves mentions
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 005 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transactions
    • 19 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sublease agreement
    Créé le 01 sept. 1994
    Livré le 19 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies from time to time payable by therapeutic antibodies inc to aberlyn capital management limited partnership by way of rent under a master lease agreement dated 31ST august 1994 made between therapeutic antibodies inc and aberlyn capital management limited partnership, whether denominated "rent", "rental payment" or "supplemental rent" thereunder and all other amounts due and payable thereunder together with vat thereon and all monies from time to time payable by tab wales limited to aberlyn capital management limited partnership under the terms of the sub-lease agreement
    Brèves mentions
    The equipment and other personal property described in exhibit a to lease schedule and acceptance certificate no 001 to the master lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aberlyn Capital Management Limited Partnership
    Transactions
    • 19 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 04 juil. 1994
    Livré le 11 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum of £7,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 97853216 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 06 juil. 1993
    Livré le 09 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Intellectual property mortgage
    Créé le 06 oct. 1992
    Livré le 13 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the welsh development agency under the terms of a secured loan agreement of even date and or this charge.
    Brèves mentions
    All the intellectual property of the company both present and future please see doc for full details,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Welsh Development Agency.
    Transactions
    • 13 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TAB WALES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 juil. 2013Dissolved on
    19 nov. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading
    practitioner
    9 Greyfriars Road
    RG1 1JG Reading

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0