POLARFROST SEAFOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOLARFROST SEAFOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01659536
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POLARFROST SEAFOODS LIMITED ?

    • Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques (46380) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe POLARFROST SEAFOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de POLARFROST SEAFOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour POLARFROST SEAFOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 juil. 2021

    7 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    42 pages600

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH à 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE le 07 mai 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW à 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH le 05 août 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 juil. 2020

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 mars 2020

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mrs Diane Susan Walker en tant qu'administrateur le 24 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jenny Nancy Loncaster en tant que directeur le 25 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Mark Busby en tant que directeur le 12 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2019 au 31 mars 2020

    1 pagesAA01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Wilkin Chapman Llp PO Box PO Box 16 New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE United Kingdom à Karro Food Group Hugden Way, Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 04 juil. 2019

    1 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 016595360010 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de POLARFROST SEAFOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Administrateur
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    WALKER, Diane Susan
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Administrateur
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBritish156683540001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Secrétaire
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    British2785890001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    WRIGHT, James Leonard
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    Secrétaire
    32 Devonshire Avenue
    DN32 0BW Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    British714180001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secrétaire
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02249348
    75197930001
    BARFORD, Peter Mark
    The Oaks
    Main Road, Barnoldby -Le-Beck
    DN37 0AU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    The Oaks
    Main Road, Barnoldby -Le-Beck
    DN37 0AU Grimsby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish34719940002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Administrateur
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritish104635350001
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandDutch166335910001
    FLEAR, Frank Alan
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    93 High Street
    Waltham
    DN37 0PN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British2785880001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Administrateur
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandBritish177239110001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    37 Brigsley Road
    Waltham
    DN37 0JX Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    37 Brigsley Road
    Waltham
    DN37 0JX Grimsby
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish31098840002
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    Grimsby
    DN31 3SW North East Lincolnshire
    EnglandBritish205633180001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Administrateur
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    REDFORD, Christopher Hugh
    11 Laburnum Avenue
    Waltham
    DN37 0JT Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    Administrateur
    11 Laburnum Avenue
    Waltham
    DN37 0JT Grimsby
    N.E. Lincolnshire
    British50912070001
    RILATT, Simon Jonathan
    14 South Rise
    Main Street Skidby
    HU16 5UH Cottingham
    East Yorkshire
    Administrateur
    14 South Rise
    Main Street Skidby
    HU16 5UH Cottingham
    East Yorkshire
    British54544170001
    RUFFELL WARD, Brian
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Tudor Garth 18a Stallingborough Road
    Healing
    DN41 7QN Grimsby
    North East Lincolnshire
    British72694900001
    SOUTHWELL, Barry
    24 Melbourne Avenue
    DN33 2AP Grimsby
    South Humberside
    Administrateur
    24 Melbourne Avenue
    DN33 2AP Grimsby
    South Humberside
    British36604930001
    STYCHE, Paul Robert
    29a Riby Road
    DN37 8ER Keelby
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    29a Riby Road
    DN37 8ER Keelby
    North East Lincolnshire
    British40834000001
    THOMAS, Andrew George
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    Administrateur
    14 Mount View
    Woodgates Lane
    HU14 3JG North Ferriby
    East Yorkshire
    British40002910008
    THOMPSON, Michael Robert
    Riverdale
    Love Lane
    LN11 9LP Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Riverdale
    Love Lane
    LN11 9LP Louth
    Lincolnshire
    British12355420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur POLARFROST SEAFOODS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 avr. 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleLaw Of England & Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03751665
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    POLARFROST SEAFOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 nov. 2015
    Livré le 09 nov. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 09 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 juil. 2013
    Livré le 25 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch
    Transactions
    • 25 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 01 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 01 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2013Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 2008
    Livré le 04 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transactions
    • 04 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 2013Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale the Security Agent
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 25 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transactions
    • 25 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2005
    Livré le 17 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transactions
    • 17 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security accession deed between the company, the parent and the security agent
    Créé le 19 mars 2002
    Livré le 30 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transactions
    • 30 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 25 oct. 1998
    Livré le 03 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the company to national westminster bank PLC as security trustee for the secured parties (as defined) and to the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 oct. 1982
    Livré le 04 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1982Enregistrement d'une charge

    POLARFROST SEAFOODS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juil. 2020Commencement of winding up
    13 janv. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0