PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01666012 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Great Cumberland Place Marble Arch W1H 7LW London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | 4.71 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Catriona Ann Wadlow en tant que directeur le 31 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Pembertons Directors Limited en tant que secrétaire le 05 juin 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR United Kingdom le 20 févr. 2012 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Pemberton Secretaries Limited Marlborough House Wigmore Place Wigmore Lane Luton LU2 9EX United Kingdom le 13 déc. 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Philip Cummings en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Catriona Ann Wadlow en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Edwards en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Edwards en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Pembertons Directors Limited en tant que secrétaire | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Queensway House 11 Queensway New Milton Hampshire BH25 5NR le 20 juin 2011 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 9 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nigel Bannister en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Mcgill en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 9 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Gaston en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Procter en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed solitaire secretaries LTD\certificate issued on 19/05/10 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINGS, Philip James | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | England | British | 169752370001 | |||||||||
| BICKNELL, Margaret | Secrétaire | The Grange Church Road IP21 4EP Thelveton Norfolk | Dutch | 104528550003 | ||||||||||
| CHRISTENSEN, David John | Secrétaire | Clinton House High Street B46 3BP Coleshill Birmingham | British | 2641650001 | ||||||||||
| COBBINA, Sam | Secrétaire | 7 Hatherley Chase LU2 7FD Luton Bedfordshire | British | 109290970002 | ||||||||||
| DAVIE, Jennifer | Secrétaire | 17 Alston Road EN5 4EU Barnet Hertfordshire | British | 20453260002 | ||||||||||
| EDWARDS, David Charles | Secrétaire | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | British | 123440090026 | ||||||||||
| GREENO, Brian George | Secrétaire | St Mary Graces Court Cartwright Street E1 8NB London 3 | Other | 129642360001 | ||||||||||
| MCCORMACK, Margaret Mary | Secrétaire | 212 Mays Lane EN5 2QQ Barnet Hertfordshire | British | 53255960002 | ||||||||||
| O'BRIEN, Bridget Geraldine | Secrétaire | 18 Jarvis Close EN5 2RH Barnet Herts | Irish | 92828050002 | ||||||||||
| PATANI, Daksha | Secrétaire | 32 The Linkway EN5 2BX Barnet Hertfordshire | British | 66819710001 | ||||||||||
| TAIWO, Bolaji | Secrétaire | 79 New Cavendish Street W1W 6XB London | Nigerian | 121659330001 | ||||||||||
| THOMAS, Lesley Amanda | Secrétaire | 27 South Cottage Gardens Chorleywood WD3 5EH Rickmansworth Hertfordshire | British | 45975530002 | ||||||||||
| UTHAYANAN, Sunthar | Secrétaire | 7 Whistler Gardens HA8 5TU Edgware Middlesex | British | 69468150001 | ||||||||||
| WINTON, Janet | Secrétaire | 22 Swan Drive NW9 5DE London | Irish | 68053050001 | ||||||||||
| WOLFSON, Alan | Secrétaire | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | 55840480004 | ||||||||||
| PEMBERTONS DIRECTORS LIMITED | Secrétaire | Queensway BH25 5NR New Milton 11 Hampshire United Kingdom |
| 161414040001 | ||||||||||
| BANNISTER, Nigel Gordon | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 117929650001 | |||||||||
| BURTON, Christopher John | Administrateur | 9 Gables Avenue WD6 4SP Borehamwood Hertfordshire | British | 2382240001 | ||||||||||
| EDWARDS, David Charles | Administrateur | 11 Queensway BH25 5NR New Milton Queensway House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 123440090026 | |||||||||
| GASTON, Michael John | Administrateur | 302 Regents Park Road Finchley N3 2JX London Molteno House United Kingdom | England | British | 94566140001 | |||||||||
| GASTON, Michael John | Administrateur | 1 Dents Road SW11 6JA London | England | British | 94566140001 | |||||||||
| MCGILL, Christopher Charles | Administrateur | The Holloway HP27 0LR Whiteleaf The Old Barn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 140593930001 | |||||||||
| O'BRIEN, Bridget Geraldine | Administrateur | 18 Jarvis Close EN5 2RH Barnet Herts | Irish | 92828050002 | ||||||||||
| PROCTER, William Kenneth, Mr. | Administrateur | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | United Kingdom | British | 98678880005 | |||||||||
| PROCTER, William Kenneth | Administrateur | 14 Church Crescent N3 1BG London | England | British | 98678880007 | |||||||||
| RAPLEY, Ian | Administrateur | 28a Ickwell Road SG18 9AB Northill Bedfordshire | United Kingdom | British | 104372330001 | |||||||||
| RAYDEN, Paul | Administrateur | 6 Elm Tree Road NW8 9JX London | England | British | 2148080003 | |||||||||
| RUSSELL, Jacqueline Anne | Administrateur | 1 Archway Street Barnes SW13 0AS London | England | British | 288404130001 | |||||||||
| SHAPIRO, Graham Ashley | Administrateur | Little Manor Hartsbourne Road WD2 1JJ Bushey Heath Hertfordshire | British | 4296340001 | ||||||||||
| SHULMAN, Harvey Barry | Administrateur | 88 Kingsley Way N2 0EN London | England | British | 1239130001 | |||||||||
| TAIWO, Bolaji | Administrateur | 79 New Cavendish Street W1W 6XB London | Nigerian | 121659330001 | ||||||||||
| TAYLOR, Alastair Desmond Barham | Administrateur | 5 Worple Avenue Wimbledon SW19 4JQ London England | England | British | 63744480001 | |||||||||
| TCHENGUIZ, Vincent Aziz | Administrateur | Park Lane W1K 1RB London 35 | United Kingdom | British | 71890500003 | |||||||||
| THOMAS, Lesley Amanda | Administrateur | 27 South Cottage Gardens Chorleywood WD3 5EH Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 45975530002 | |||||||||
| TONKIN, Charles Barrie | Administrateur | 1 Stonecroft Close Barnet Road EN5 3HE Arkley, Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 48915540001 |
PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 08 nov. 2006 Livré le 22 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
PEMBERTONS SECRETARIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0