KENMAC HAULAGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENMAC HAULAGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01667548
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENMAC HAULAGE LIMITED ?

    • (6024) /

    Où se situe KENMAC HAULAGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KENMAC HAULAGE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAULACE LIMITED27 sept. 198227 sept. 1982

    Quels sont les derniers comptes de KENMAC HAULAGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour KENMAC HAULAGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 14 juin 2012

    10 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 09 déc. 2011

    9 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 09 juin 2011

    8 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    21 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    21 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Building 76 Greenfield Business Park 2 Greenfield Holywell Flintshire CH8 7HJ le 04 janv. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2010

    État du capital au 17 juin 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    legacy

    7 pagesMG01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages395

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    3 pages395

    Qui sont les dirigeants de KENMAC HAULAGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STRETTON, Susan
    St Davids Court
    Connah's Quay
    CH5 4EW Deeside
    22
    Flintshire
    Secrétaire
    St Davids Court
    Connah's Quay
    CH5 4EW Deeside
    22
    Flintshire
    Other139861610001
    DAVIES, William Kenneth
    4 St Winifred's Court
    Whitford Street
    CH8 7NL Holywell
    Clwyd
    Administrateur
    4 St Winifred's Court
    Whitford Street
    CH8 7NL Holywell
    Clwyd
    United KingdomBritish67731350001
    JONES, Gareth Wyn
    32 Taliesin Avenue
    Shotton
    CH5 1HY Deeside
    Flintshire
    Secrétaire
    32 Taliesin Avenue
    Shotton
    CH5 1HY Deeside
    Flintshire
    British60831490002
    KENDRICK, John Edward
    18 Fletcher Drive
    Bowdon
    WA14 3FZ Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    18 Fletcher Drive
    Bowdon
    WA14 3FZ Altrincham
    Cheshire
    British37891720002
    REECE, William John Stanley
    14 Calthorpe Drive
    LL19 9RF Prestatyn
    Clwyd
    Secrétaire
    14 Calthorpe Drive
    LL19 9RF Prestatyn
    Clwyd
    British62976800001
    JONES, John Kenneth
    Ty Uchaf
    Gwaenysgor
    LL18 6EW Rhyl
    Denbighshire
    Administrateur
    Ty Uchaf
    Gwaenysgor
    LL18 6EW Rhyl
    Denbighshire
    United KingdomBritish12678750001
    MCLEAN, David Charles
    Bryn Bella
    Lloc
    CH8 8RQ Holywell
    Flintshire
    Administrateur
    Bryn Bella
    Lloc
    CH8 8RQ Holywell
    Flintshire
    British12678740001

    KENMAC HAULAGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 mars 2010
    Livré le 31 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Absolute Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 31 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 10 avr. 2008
    Livré le 11 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 76 greenfield business park 2 greenfield holywell flintshire with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 2007
    Livré le 12 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 avr. 2007
    Livré le 25 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 25 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 2006
    Livré le 30 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company, the chargor or by some other person of the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and property k/a building 76, greenfield business park 2, bagillt road, greenfield, holywell, clwyd, the related rights and goodwill by way of fixed charge and all present and future assets by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commercial First Business Limited
    Transactions
    • 30 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 03 avr. 2006
    Livré le 04 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage, f/h or l/h property, all plant, machinery, equipment, vehicles, all book debts, goodwill and a floating charge on all its undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Excel-a-Rate Business Services LTD
    Transactions
    • 04 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 21 janv. 2005
    Livré le 27 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Volvo FM12 8X4 340 bhp reg PJ52HKU chass YV2J4CMG53A559873 dor 10.01.2003 volvo FM12 8X4 340 bhp reg PJ52HKT chass YV2J4CMG33A559872 dor 10.01.2003 volvo FM12 8X4 340 bhp reg chass YV2J4CMG63A560675 dor 21.01.2003 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trust PLC
    Transactions
    • 27 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 1998
    Livré le 21 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two loan agreements of even date between the company and the chargee and/or under clause 6 of a share sale agreement of even date with the debenture made between the company, the chargee and william kenneth davies
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • David Mclean (Holdings) Limited
    Transactions
    • 21 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 1998
    Livré le 17 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 oct. 1998
    Livré le 17 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at land & buildings at 76 greenfield business park,greenfield,holywell.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 oct. 1998
    Livré le 17 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at land adjoining greenfield business park greenfield holywell.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 24 août 1998
    Livré le 27 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts between the company and the chargee or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Credit Services Limited
    Transactions
    • 27 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 11 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Land adjoining building 76 greenfield business park greenfield holywell flintshire.
    Personnes ayant droit
    • Flintshire County Council
    Transactions
    • 11 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 10 nov. 1992
    Livré le 26 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See doc ref M523C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 nov. 1987
    Livré le 04 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings south east of merllyn lane, pen y bont, bagillt, clwyd title no. Wa 5479.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 02 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 juin 1985
    Livré le 15 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 29 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    KENMAC HAULAGE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 juin 2012Administration ended
    10 déc. 2010Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Tim Alan Askham
    Mazars Llp Mazars House
    Gelderd Road
    LS27 7JN Gildersome
    Leeds
    practitioner
    Mazars Llp Mazars House
    Gelderd Road
    LS27 7JN Gildersome
    Leeds
    Robert David Adamson
    Mazars House
    Gelderd Road
    LS27 7JN Gildersome
    Leeds
    practitioner
    Mazars House
    Gelderd Road
    LS27 7JN Gildersome
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0