SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01669220 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED ?
Adresse du siège social | Jephson Court Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Warwickshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Restauration par ordonnance du tribunal | 3 pages | AC92 | ||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 12 déc. 2016
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 13 pages | AA | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA à Jephson Court Tancred Close Leamington Spa CV31 3RZ | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Abogado Nominees Limited en tant que secrétaire le 10 févr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr. Eoin Muldowney en tant qu'administrateur le 29 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr. Andrew Jackson en tant qu'administrateur le 28 mai 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Gerard Mullin en tant que directeur le 28 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Gerard Mullin le 22 mars 2014 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Abogado Nominees Limited le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon David Whittaker en tant que directeur le 27 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKSON, Andrew | Administrateur | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | Finance Director | 199276600001 | ||||||||
MULDOWNEY, Eoin | Administrateur | 30 Pembroke Road Ballsbridge Dublin Eaton House Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 202723220001 | ||||||||
DIAS, Raymond | Secrétaire | 1 Castlereagh House Lady Aylesford Avenu HA7 4FP Stanmore Middlesex | British | 102027890001 | ||||||||||
HELZ, Terrance Valentine | Secrétaire | 11 China Rose Court The Woodlands Texas 77381 Usa | American | 61652840001 | ||||||||||
HERBERT, Karen Elizabeth | Secrétaire | 10 Aylesbury Court 77479 Sugarland Texas America | British | 37383450001 | ||||||||||
JAMES, Gavin Keith | Secrétaire | Gable House Church End CV23 8SN Priors Hardwick Warwickshire | British | Director | 44173560002 | |||||||||
JARRETT, Marilyn Frances | Secrétaire | 47 Warkworth Close OX16 1BD Banbury Oxfordshire | British | Company Secretary | 64181020001 | |||||||||
LANDERS, Gerard Francis | Secrétaire | 36 Lancaster Road UB8 1AR Uxbridge Middlesex | British | 22519060001 | ||||||||||
ABOGADO NOMINEES LIMITED | Secrétaire désigné | 100 New Bridge Street EC4V 6JA London |
| 900021150001 | ||||||||||
ALLEN, Anthony Thaddeus | Administrateur | Hillside Llansoy NP15 1DF Usk Gwent | Wales | British | Director | 64198880001 | ||||||||
BEYEN, Kris Maria August | Administrateur | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire | United Kingdom | Belgian | Business Executive | 157565820001 | ||||||||
BROOKES, Christopher | Administrateur | Woodacres Nightingales Lane HP8 4SG Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | Company Director | 16102860001 | |||||||||
FLETCHER, Roger Barrett | Administrateur | Montroig Mollington OX17 1BP Banbury Oxfordshire | British | Director | 16260890001 | |||||||||
GAWRONSKI, Grant Lawrence | Administrateur | 19 Hunters Crossing Court The Woodlands Texas 77381 Usa | Usa | American | Business Executive | 115387690001 | ||||||||
HAACK, Axel Gottfried Gunther | Administrateur | 9 Haute Corniche 67210 Obernai France | German | Business Executive | 120071580001 | |||||||||
HURST, Barrie | Administrateur | Norwood Chapel Lane Bodicote OX15 4DB Banbury Oxfordshire | England | British | Director | 16260900001 | ||||||||
JAMES, Gavin Keith | Administrateur | Gable House Church End CV23 8SN Priors Hardwick Warwickshire | British | Director | 44173560002 | |||||||||
KERNOT, David | Administrateur | 2 Drayton Close Swindon GL51 9QB Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 58384980001 | |||||||||
KNEIS, Thomas David | Administrateur | 6 Galsworthy Drive RG4 0PD Caversham Park Village Berkshire | American | Company Director | 53129310001 | |||||||||
LANDERS, Gerard Francis | Administrateur | 36 Lancaster Road UB8 1AR Uxbridge Middlesex | British | Chartered Accountant | 22519060001 | |||||||||
MULLIN, Martin Gerard | Administrateur | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court Warwickshire England | England | British | Vice President & Gm | 150271550001 | ||||||||
SCRIMSHAW, James Eric | Administrateur | Dove House Temple Grafton B49 6NT Alcester Warwickshire | British | Company Director | 60793220002 | |||||||||
SNOOK, David Norman | Administrateur | Tybee Forty Green Road Knotty Green HP9 1XL Beaconsfield Buckinghamshire | English | 16102870001 | ||||||||||
WHITTAKER, Simon David | Administrateur | Tancred Close Queensway CV31 3RZ Royal Leamington Spa Jephson Court Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 115390050002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scantronic Holdings Limited | 28 juil. 2016 | Tancred Close CV31 3RZ Leamington Spa Jephson Court England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SCANTRONIC INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Créé le 06 oct. 1994 Livré le 13 oct. 1994 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 13 oct. 1993 Livré le 21 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 févr. 1988 Livré le 07 mars 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0