SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED

SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01674987
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED ?

    • Activités des agences de voyages (79110) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O INTERPATH LTD
    10th Floor One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DUNDON LIMITED01 nov. 198201 nov. 1982

    Quels sont les derniers comptes de SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    27 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    27 pagesAM10

    Changement d'adresse du siège social de 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE à 10th Floor One Marsden Street Manchester M2 1HW le 21 mars 2022

    2 pagesAD01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Avis de nomination d'un administrateur remplaçant ou supplémentaire

    5 pagesAM11

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    5 pagesAM16

    Avis de prolongation du délai de l'administration

    3 pagesAM04

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    29 pagesAM16

    Avis de nomination d'un administrateur remplaçant ou supplémentaire

    3 pagesAM11

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    25 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10

    Nomination de Mr Hugo Charles Kimber en tant qu'administrateur le 02 août 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Daniel Mclaughlin en tant qu'administrateur le 02 août 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Daniel Mclaughlin en tant que directeur le 02 août 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Hugo Charles Kimber en tant que directeur le 02 août 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    56 pagesAM03

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    19 pagesAM02

    Changement d'adresse du siège social de . Eboracum Way Heworth Green York Yorkshire YO31 7RE à 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE le 21 août 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Qui sont les dirigeants de SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KERKAR, Ajay Ajit Peter
    One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    10th Floor
    Administrateur
    One Marsden Street
    M2 1HW Manchester
    10th Floor
    United KingdomIndianCompany Director171005990001
    KIMBER, Hugo Charles
    St. Katharines
    Savernake
    SN8 3BG Marlborough
    St. Katharines Lodge
    England
    Administrateur
    St. Katharines
    Savernake
    SN8 3BG Marlborough
    St. Katharines Lodge
    England
    EnglandBritishDirector113847000002
    MCLAUGHLIN, John Daniel
    Brookfield Drive
    Timperley
    WA15 6QR Altrincham
    22
    England
    Administrateur
    Brookfield Drive
    Timperley
    WA15 6QR Altrincham
    22
    England
    United KingdomBritishDirector230948990001
    BADDELEY, Robert Gregory
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    2 Devisdale Grange
    Groby Road Bowdon
    WA14 2BY Altrincham
    Cheshire
    BritishVd28024220004
    CULLEN, Dominique
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    Secrétaire
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    195246800001
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    192247070001
    MICHEL, Carl Heinrich
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    Secrétaire
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    BritishDirector107791560001
    WILLIAMSON, Alexandra Dilys
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    British100325220002
    WRAY, Mark Christopher
    32 Hillcrest Avenue
    Nether Poppleton
    YO2 6LD York
    Secrétaire
    32 Hillcrest Avenue
    Nether Poppleton
    YO2 6LD York
    British25762230002
    ALLAN, Leslie Stewart
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    Administrateur
    78 Honor Oak Road
    SE23 3RR London
    BritishCompany Director1704690001
    ANDERSON, Ian David
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector163172340002
    ATKINS, Jane Louise
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    Administrateur
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector207125210001
    ATKINSON, Richard Westaway
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishDirector111861370001
    BADDELEY, Robert Gregory
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Great BritainBritishCompany Director28024220020
    BALI, Navneet
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director83088120002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director180993450001
    CREW, James Robert
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector15842470001
    CUST, Nicholas Pury
    Crookhill
    The Village Skelton
    YO3 6XY York
    Administrateur
    Crookhill
    The Village Skelton
    YO3 6XY York
    United KingdomBritishJoint Managing Director159977730001
    DAVIES, Martin William Oliver
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector98399000002
    FENNEMORE, Roger Arnold
    25 Chapel Street
    Woburn Sands
    MK17 8PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    25 Chapel Street
    Woburn Sands
    MK17 8PG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director9399600002
    FERRIN, Eamonn
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United KingdomIrishCompany Director146776900001
    GOENKA, Abhishek
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    Administrateur
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    United KingdomIndianGeneral Manager192234860001
    HOPE, Stuart Malcolm Ronald
    8 Nesbitt Square
    Coxwell Road
    SE19 3AB London
    Administrateur
    8 Nesbitt Square
    Coxwell Road
    SE19 3AB London
    BritishExecutive Director49358260001
    JARVIS, Susan
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    Administrateur
    Eboracum Way
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    .
    Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director199100680002
    JONES, Raymond Anthony Patrick
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector60728450001
    KIMBER, Hugo Charles
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Administrateur
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    EnglandBritishExecutive Chairman113847000002
    LEPPARD, Matin Neal
    Parkfield House Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Parkfield House Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director44209650001
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    EnglandBritishTreasurer27408660003
    MCLAUGHLIN, John Daniel
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Limited
    Uk
    United Kingdom
    Administrateur
    30 Millbank
    SW1P 4DU London
    3rd Floor, C/O Holidaybreak Limited
    Uk
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer230948990001
    MENON, Ajit Paramparambath
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director170912720001
    MICHEL, Carl Heinrich
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    Administrateur
    2 College Place
    Hortensia Road
    SW10 0QZ London
    EnglandBritishDirector107791560001
    MOUNSER, Ian Peter
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTour Operator50419570001
    NEYLON, Darren Lee
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishCompany Director69978820001
    REGAN, Frank
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTour Operator35768770001
    RICHARDS, Patrick Rory
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    England
    EnglandBritishCompany Director135751860001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Superbreak Mini Holidays Group Limited
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Heworth Green
    YO31 7RE York
    Eboracum Way
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUk Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Companies Registry
    Numéro d'enregistrement2501443
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 févr. 2019
    Livré le 26 févr. 2019
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 nov. 2018
    Livré le 05 déc. 2018
    En cours
    Brève description
    Registered trade mark with tm number UK00002143013; registered trade mark with tm number UK00002372700; registered trade mark with tm number UK00001382488; registered trade mark with tm number UK00001525779; and registered trade mark with tm number UK00002000435. For more information please see schedule 1 of the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Yes Bank Limited, Ifsc Banking Unit (As Lender as Defined in the Debenture))
    Transactions
    • 05 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 nov. 2018
    Livré le 05 déc. 2018
    En cours
    Brève description
    N/A.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Yes Bank Limited, Ifsc Banking Unit (As Lender (as Defined in the Share Charge))
    Transactions
    • 05 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 04 sept. 2014
    Livré le 15 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 avr. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 23 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 sept. 2014
    Livré le 15 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 avr. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 23 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Dutch law notarial deed of pledge of shares
    Créé le 29 juin 2012
    Livré le 13 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pledge and pledges as a disclosed right of pledge to the facility agent all its shares and share rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The Facility Agent)
    Transactions
    • 13 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 avr. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 23 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    English law security agreement
    Créé le 29 juin 2012
    Livré le 13 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 avr. 2016L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 23 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of pledge of shares
    Créé le 09 mai 2008
    Livré le 19 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All shares and share rights including any dividend. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 09 mai 2008
    Livré le 16 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Hartford manor hartford northwich t/no CH424893. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 16 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 28 sept. 2002
    Livré le 02 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits credited to account numbered 45992614 and any deposit or account of any other currency description or designation.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 01 août 2000
    Livré le 16 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities of each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the banking documents to which such charging company is a party
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to the debenture dated 3RD february 1995
    Créé le 09 févr. 1998
    Livré le 11 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities at the date of the supplemental deed or thereafter due owing or incurred by the company to national westminster bank PLC (the "security trustee") and to the beneficiaries (as defined) or any of them (whether under the facility agreements,and the facility documents as defined or otherwise) and by guarantee the obligations of each other company and any other subsidiary of the parent (the guaranteed obligations)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 juil. 1995
    Livré le 14 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for and on behalf of the beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether under any of the facility agreements, the facility documents (as defined therein) or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge
    Créé le 01 juil. 1992
    Livré le 06 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee and debenture dated 14/6/90
    Brèves mentions
    L/H property k/a lower ground floor of 297/305 grays inn road london.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 juin 1990
    Livré le 29 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or antfresh limited under the terms of the charge to the chargee.
    Brèves mentions
    (See doc M248 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 janv. 1985
    Livré le 23 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Please see doc M15.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Letter of charge
    Créé le 01 juil. 1983
    Livré le 21 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re: dunn miller associates LTD.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 05 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SUPERBREAK MINI-HOLIDAYS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 août 2019Administration started
    05 août 2022Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    practitioner
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Tracey Lee Pye
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    practitioner
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Richard John Harrison
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    practitioner
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Andrew James Stone
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    practitioner
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0