PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPUNCH TAVERNS (MH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01676516
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PUNCH RETAIL (MANAGED HOLDINGS) LIMITED05 juin 200005 juin 2000
    BOSTON DINER LIMITED(THE)17 janv. 198317 janv. 1983
    CHIEFBADGE LIMITED09 nov. 198209 nov. 1982

    Quels sont les derniers comptes de PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 30 mars 2021

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    86 pagesPARENT_ACC

    legacy

    2 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Cessation de la nomination de David Forde en tant que directeur le 31 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    legacy

    2 pagesAGREEMENT1

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    legacy

    79 pagesPARENT_ACC

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Sean Michael Paterson en tant qu'administrateur le 23 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David James Tannahill en tant que directeur le 24 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 016765160005 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Période comptable actuelle prolongée du 24 août 2018 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 19 août 2017

    4 pagesAA

    Modification des détails de Punch Taverns (Fh) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept. 2017

    2 pagesPSC05

    Qui sont les dirigeants de PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Administrateur
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628760001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175489270001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161798500001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishSecretary637110001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector180590780001
    JONAS, Marc Nicholas
    48 Oxford Gardens
    W10 5UN London
    Administrateur
    48 Oxford Gardens
    W10 5UN London
    United KingdomBritishCorporate Financier55841850003
    JONES, Bruce Abbott
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    Administrateur
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    BritishCompany Director29595900002
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    31 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    Administrateur
    31 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    BritishDirector47793260004
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Administrateur
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritishDirector79388130005
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Administrateur
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    BritishDirector46361590002
    OGINSKY, Kenneth Arnold
    41 Pinfold Hill
    WS14 0JN Shenstone
    Staffordshire
    Administrateur
    41 Pinfold Hill
    WS14 0JN Shenstone
    Staffordshire
    BritishAccountant39198500001
    OSMOND, Hugh
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    Administrateur
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    BritishDirector6209210002
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Administrateur
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwissManaging Director78412270001
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector237381690001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritishDirector81928120001
    WHITEHEAD, Gordon William George
    Rosedale
    24 Jacks Lane
    ST14 8LW Marchington
    Staffordshire
    Administrateur
    Rosedale
    24 Jacks Lane
    ST14 8LW Marchington
    Staffordshire
    BritishAccountant13507460001
    WILKINSON, Anthony Eric
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director4656080002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 août 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCorporate
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc065527
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Punch Taverns (Fh) Limited
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PUNCH TAVERNS (MH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 08 oct. 2014
    Livré le 15 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited as Security Trustee for the Punch Taverns Secured Parties
    Transactions
    • 15 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Third supplemental deed of charge
    Créé le 03 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited (Or Such Other Person Acting as Security Trustee Under Thepunch Taverns First Priority Deed of Charge) (the "Security Trustee")
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Third supplemental pr deed of charge
    Créé le 15 mai 2003
    Livré le 02 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the pr secured parties)or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title benefit and interest present and future in to and under the pr (af) l subordinated loan and the framework agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transactions
    • 02 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge
    Créé le 22 avr. 2002
    Livré le 08 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transactions
    • 08 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed 0F charge
    Créé le 28 juin 2000
    Livré le 15 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties, or any other guarantor, under or in respect the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction document (as defined therein)
    Brèves mentions
    All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited "the Security Trustee" (As Defined Therein)
    Transactions
    • 15 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 24 janv. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 27 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0