QS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQS PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 01682473
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QS PLC ?

    • Vente au détail de vêtements en magasin spécialisé (47710) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe QS PLC ?

    Adresse du siège social
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QS PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    QS LIMITED24 janv. 200324 janv. 2003
    Q S PLC06 juin 199706 juin 1997
    QS FAMILYWEAR PLC13 juil. 198713 juil. 1987
    QUALITY SECONDS LIMITED27 juin 198327 juin 1983
    EQUICANE LIMITED29 nov. 198229 nov. 1982

    Quels sont les derniers comptes de QS PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour QS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    21 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 27 déc. 2016

    19 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    34 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    34 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    7 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Alok House, Drayton Road, Shirley, Solihull Drayton Road Shirley Solihull West Midlands B90 4NG à The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB le 08 juil. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Anupam Jhunjhunwala en tant que directeur le 19 mars 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 janv. 2016

    État du capital au 04 janv. 2016

    • Capital: GBP 1,701,264
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Turek House Drayton Road Shirley Solihull West Midlands B90 4NG à Alok House, Drayton Road, Shirley, Solihull Drayton Road Shirley Solihull West Midlands B90 4NG le 04 janv. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 28 mars 2015

    11 pagesAA

    Nomination de Mr. Pravin Soni en tant qu'administrateur le 21 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 janv. 2015

    État du capital au 13 janv. 2015

    • Capital: GBP 1,701,264
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anupam Jhunjhunwala le 12 nov. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 29 mars 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 déc. 2013

    État du capital au 20 déc. 2013

    • Capital: GBP 1,701,264
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 mars 2013

    12 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 29 juin 2013 au 31 mars 2013

    1 pagesAA01

    Période comptable actuelle prolongée du 01 avr. 2013 au 29 juin 2013

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr. Mark Westmoreland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Nomination de Mr Pravin Soni en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de QS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SONI, Pravin
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Secrétaire
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    173832780001
    SONI, Pravin
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Administrateur
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritishDirector194377340001
    TATLA, Kingpal Singh
    47 London Road
    SL3 7RP Slough
    Berkshire
    Administrateur
    47 London Road
    SL3 7RP Slough
    Berkshire
    EnglandBritishDirector17340880001
    WESTMORELAND, Mark, Mr.
    Plot C1 Central Boulevard
    Blyth Valley Business Park
    B908ah
    Solihull
    Unit 1
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Plot C1 Central Boulevard
    Blyth Valley Business Park
    B908ah
    Solihull
    Unit 1
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director46696800003
    AHMED, Mohi
    Turek House Drayton Road
    Shirley
    B90 4NG Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    Turek House Drayton Road
    Shirley
    B90 4NG Solihull
    West Midlands
    159978330001
    HOLES, Eric
    3 Standen Close
    Felbridge
    RH19 2RL East Grinstead
    West Sussex
    Secrétaire
    3 Standen Close
    Felbridge
    RH19 2RL East Grinstead
    West Sussex
    British27021670003
    KAPOOR, Vivek
    Blossomfield Gardens 34 Blossomfield Road
    B91 1NZ Solihull
    2
    West Midlands
    Uk
    Secrétaire
    Blossomfield Gardens 34 Blossomfield Road
    B91 1NZ Solihull
    2
    West Midlands
    Uk
    IndianAccountant130538380001
    KENNEDY, Raymond
    6 Church Fields
    TN22 3NA Nutley
    East Sussex
    Secrétaire
    6 Church Fields
    TN22 3NA Nutley
    East Sussex
    British118207520001
    LITTLE, Mark John James
    Farringford
    Harlestone Road
    NN6 8AU Church Brampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Farringford
    Harlestone Road
    NN6 8AU Church Brampton
    Northamptonshire
    BritishAccountant149016530001
    WILSON, Kerry Alan
    35 Dover Road
    BN1 6LP Brighton
    East Sussex
    Secrétaire
    35 Dover Road
    BN1 6LP Brighton
    East Sussex
    BritishAccountant113431630001
    APPLEBY, Paulette Anne
    27 Hart Close
    West Park
    TN22 2DA Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    27 Hart Close
    West Park
    TN22 2DA Uckfield
    East Sussex
    BritishIt Director56845990002
    BACON, Paul
    33 Trevelyan Place
    Heath Road
    RH16 3AZ Haywards Heath
    Administrateur
    33 Trevelyan Place
    Heath Road
    RH16 3AZ Haywards Heath
    BritishBuying Director63456100004
    BATE, Jennifer Ann
    Boxmoor
    Wood Road
    GU26 6PX Hindhead
    Surrey
    Administrateur
    Boxmoor
    Wood Road
    GU26 6PX Hindhead
    Surrey
    BritishDirector50186650001
    BERRY, Mabel Geogina Elenor
    Highlands Farm 7 High Lane
    CR6 9DQ Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    Highlands Farm 7 High Lane
    CR6 9DQ Warlingham
    Surrey
    BritishDirector10972720001
    BERRY, Rita Kathleen Theresa
    High Leas High Lane
    CR6 9DQ Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    High Leas High Lane
    CR6 9DQ Warlingham
    Surrey
    EnglandBritishDirector8675370001
    CALDWELL, Findlay Martin
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Heronswood Ford Lane
    Langley
    CV37 0HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GbBritishDirector50777030001
    CHATHA, Rajinder Singh
    Aqualate Manor
    Stafford Road
    TF10 9BY Newport
    Shropshire
    Administrateur
    Aqualate Manor
    Stafford Road
    TF10 9BY Newport
    Shropshire
    BritishDirector5023790002
    DHAMECHA, Pradip Khodidas
    2 Hathaway Close
    HA7 3NR Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    2 Hathaway Close
    HA7 3NR Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish,Garment Wholesaler93230640001
    ESPLIN, Christine Anne
    22 Churchmead
    Keymer
    BN6 8BN Hassocks
    West Sussex
    Administrateur
    22 Churchmead
    Keymer
    BN6 8BN Hassocks
    West Sussex
    BritishPersonnel Director33815090001
    FONTAINE, Mark Philip
    6 Lickey Grange Drive
    Marlbrook
    B60 1RD Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    6 Lickey Grange Drive
    Marlbrook
    B60 1RD Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishAccountant40505630003
    GRAHAM, John James
    Home Farm
    RH20 Washington
    West Sussex
    Administrateur
    Home Farm
    RH20 Washington
    West Sussex
    BritishDirector27021690001
    GRIFFITHS, David Thomas Henry
    15 Coltsfoot Drive
    RH12 5FH Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    15 Coltsfoot Drive
    RH12 5FH Horsham
    West Sussex
    BritishRetail Director54308440001
    HOLES, Eric
    3 Standen Close
    Felbridge
    RH19 2RL East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    3 Standen Close
    Felbridge
    RH19 2RL East Grinstead
    West Sussex
    BritishDirector27021670003
    INGRAM, David Colin
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    BritishAccountant109149390001
    JHUNJHUNWALA, Anupam
    Woodhouse Eaves
    HA6 3NF Northwood
    33
    Middlesex
    Administrateur
    Woodhouse Eaves
    HA6 3NF Northwood
    33
    Middlesex
    United KingdomBritishAccountant120872450001
    KENNEDY, Raymond
    6 Church Fields
    TN22 3NA Nutley
    East Sussex
    Administrateur
    6 Church Fields
    TN22 3NA Nutley
    East Sussex
    United KingdomBritishAccountant118207520001
    KHELA, Surjeet Singh
    Fenay Court Fenay Lane
    Almondbury
    HD5 8UJ Huddersfield
    Administrateur
    Fenay Court Fenay Lane
    Almondbury
    HD5 8UJ Huddersfield
    BritishGarment Wholesaler3462380002
    LEACH, Peter Markham
    2 Rock Farm Oast
    Gibbs Hill, Nettlestead
    ME18 5HT Maidstone
    Kent
    Administrateur
    2 Rock Farm Oast
    Gibbs Hill, Nettlestead
    ME18 5HT Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishRetail Director82205030001
    NAIRN, Iain Wishart
    Greenhurst
    Greenhurst Lane
    RH20 3HA Thakeham
    West Sussex
    Administrateur
    Greenhurst
    Greenhurst Lane
    RH20 3HA Thakeham
    West Sussex
    BritishRetail Director86506520001
    NARAYAN, Rangaswamy
    Apt 93 Orion Building
    90 Navigation Street
    B5 4AA Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    Apt 93 Orion Building
    90 Navigation Street
    B5 4AA Birmingham
    West Midlands
    IndianDirector121059200001
    PARKINSON, Alan John
    Summerleas
    North Drive
    BN16 4JJ Angmering
    West Sussex
    Administrateur
    Summerleas
    North Drive
    BN16 4JJ Angmering
    West Sussex
    BritishMerchandise Director68015440001
    WALTERS, Marc
    32 Dyke Road Avenue
    BN1 5LB Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    32 Dyke Road Avenue
    BN1 5LB Brighton
    East Sussex
    BritishDirector27021700001
    WANSTALL, Neil Robert
    Flat 26 Woodside Lodge
    BN1 5ND Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    Flat 26 Woodside Lodge
    BN1 5ND Brighton
    East Sussex
    BritishDirector19610990002
    ZONJEE, Annlyn
    11 Blackfields Avenue
    TN39 4JL Bexhill-On-Sea
    East Sussex
    Administrateur
    11 Blackfields Avenue
    TN39 4JL Bexhill-On-Sea
    East Sussex
    BritishRegional Stores Director68458020001

    QS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 mars 2009
    Livré le 28 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 04 mai 2005
    Livré le 13 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the charging companies to each of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Whittalls Wines Limited as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 13 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 25 february 2003 and
    Créé le 04 oct. 2003
    Acquis le 31 mai 2006
    Livré le 14 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a unit 1 29 market place, devizes, 54/55 taff street, pontypridd, 40 sandgate road, folkestone for further property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 2006Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 02 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 févr. 2003
    Acquis le 31 mai 2006
    Livré le 14 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a 54 high street, bognor regis, the property k/a 66 high street, christchurch, the property k/a 44 high street, epsom for further property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juin 2006Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 02 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 févr. 2003
    Livré le 28 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 févr. 2003
    Livré le 20 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 20 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent security deposit deed
    Créé le 03 févr. 2000
    Livré le 07 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The rent payable under and the performance of the covenants on the part of the tenant (the company) to the chargee contained in a lease dated 24TH may 1996
    Brèves mentions
    The deposit of £36,425 together with all interest earned thereon and any further sums which the company pays from time to time pursuant to the deed.
    Personnes ayant droit
    • Development Securities (Investments) PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of charge
    Créé le 26 mai 1983
    Livré le 16 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing of the credit of any account (s) of the company with the bank designated barclays bank PLC re equireanl limited treasures deposit.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 26 mai 1983
    Livré le 15 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1983Enregistrement d'une charge

    QS PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 févr. 2006Administration started
    27 juil. 2007Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Brian Shierson
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    practitioner
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Martin Gilbert Ellis
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    Grant Thornton House
    NW1 2EP Melton Street
    Euston Square London
    Daniel Robert Whiteley Smith
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    practitioner
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    2
    DateType
    28 juin 2016Administration started
    27 juin 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ryan Kevin Grant
    Alix Partners Services Uk Llp
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    practitioner
    Alix Partners Services Uk Llp
    35 Newhall Street
    B3 3PU Birmingham
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0