WILLIAMS (2016) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWILLIAMS (2016) LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 01683477
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WILLIAMS CHEMISTS LIMITED10 avr. 199110 avr. 1991
    SUREVALUE LIMITED02 déc. 198202 déc. 1982

    Quels sont les derniers comptes de WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au11 janv. 2015

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 juil. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Forms b & z convert to rs
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to rs 22/08/2016
    RES13

    État du capital après une attribution d'actions au 22 août 2016

    • Capital: GBP 82
    3 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Déclaration de confirmation établie le 31 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 août 2015

    État du capital au 13 août 2015

    • Capital: GBP 80
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2015

    4 pagesAA

    Nomination de Cws (No.1) Limited en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP02

    Cessation de la nomination de John Branson Nuttall en tant que directeur le 06 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Anthony Philip James Crossland en tant qu'administrateur le 06 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony John Smith en tant que directeur le 06 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 août 2014

    État du capital au 22 août 2014

    • Capital: GBP 80
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 août 2013

    État du capital au 15 août 2013

    • Capital: GBP 80
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Branson Nuttall le 31 juil. 2013

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 31 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2013

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES United Kingdom* le 04 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 11 janv. 2011

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Branson Nuttall le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150139190001
    CROSSLAND, Anthony Philip James
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish125492370001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1925625
    130695310001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Secrétaire
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    British84868550001
    WILLIAMS, Susan Elizabeth
    Rose Farm Cottage
    Course Lane Newburgh
    WN8 7UG Wigan
    Lancs
    Secrétaire
    Rose Farm Cottage
    Course Lane Newburgh
    WN8 7UG Wigan
    Lancs
    British15359360001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    CHALMERS, Arthur
    39 Catterick Road
    Didsbury
    M20 6HF Manchester
    Administrateur
    39 Catterick Road
    Didsbury
    M20 6HF Manchester
    British59818810001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Administrateur
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    FLINT, Robert Geoffrey
    West View Sutherland Road
    Longsdon
    ST9 9QP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    West View Sutherland Road
    Longsdon
    ST9 9QP Stoke On Trent
    Staffordshire
    British44966790001
    HERITAGE, Joanna Leigh
    6 Stuart Drive
    Stockton Heath
    WA4 2BT Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    6 Stuart Drive
    Stockton Heath
    WA4 2BT Warrington
    Cheshire
    British65084600001
    JONES, Neil Garth
    5 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    5 Quayside Mews
    WA13 0HZ Lymm
    Cheshire
    British47680730001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Administrateur
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    EnglandBritish84868550001
    NUTTALL, John Branson
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish44967060003
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Administrateur
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish137558680002
    SNAPE, Jonathan Matthew
    3 Rowan Close
    Alsager
    ST7 2RZ Stoke On Trent
    Administrateur
    3 Rowan Close
    Alsager
    ST7 2RZ Stoke On Trent
    British47680910001
    THOMPSON, Christopher Howard Gould
    1 Norfolk Road
    HG2 8DA Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    1 Norfolk Road
    HG2 8DA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish38632440001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    WILLIAMS, Michael Arthur
    Rose Farm Cottage
    Course Lane Newburgh
    WN8 7UG Wigan
    Lancs
    Administrateur
    Rose Farm Cottage
    Course Lane Newburgh
    WN8 7UG Wigan
    Lancs
    British15359370001
    WILLIAMS, Susan Elizabeth
    Rose Farm Cottage
    Course Lane Newburgh
    WN8 7UG Wigan
    Lancs
    Administrateur
    Rose Farm Cottage
    Course Lane Newburgh
    WN8 7UG Wigan
    Lancs
    British15359360001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Administrateur
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WILLIAMS (2016) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    31 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WILLIAMS (2016) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 1992
    Livré le 08 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 11 rainford road billinge and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 mai 1992
    Livré le 08 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The pharmacy recreation drive billinge st helens merseyside t/n ms 305090AND/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 avr. 1987
    Livré le 29 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 12 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 août 1984
    Livré le 24 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    St. Mary's pharmacy, horsedge, street, oldham and/or the proceeds of sale thereof. Title no: gm 212090.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 12 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0