TUNSTALL VITALCALL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TUNSTALL VITALCALL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01687626 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?
| Adresse du siège social | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 5 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 29 sept. 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Shaun Parker en tant que secrétaire le 04 sept. 2014 | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Jonathan Paul Furniss en tant que secrétaire le 04 sept. 2014 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Shaun Parker en tant que secrétaire | 3 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Webster en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Shaun Parker en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Webster en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Paul Lancelot Stobart en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gil Baldwin en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Dyson en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Dyson en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Richard Philip James Webster en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Richard Philip James Webster en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FURNISS, Jonathan Paul | Secrétaire | Whitley Bridge DN14 0HR Doncaster Whitley Lodge Yorkshire | British | 191128080001 | ||||||
| PARKER, Shaun | Administrateur | Whitley Bridge DN14 0HR Doncaster Whitley Lodge West Yorkshire | United Kingdom | British | 100048680001 | |||||
| STOBART, Paul Lancelot | Administrateur | Doncaster Road DN14 0HR Whitley Bridge Whitley Lodge Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 175694060001 | |||||
| ATTWELL, Simon John | Secrétaire | Appletree House Newton Road YO61 1QX Tollerton York | British | 41138740002 | ||||||
| DUFFY, Neil Anthony | Secrétaire | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | British | 89484760003 | ||||||
| DYSON, Kevin Frederick | Secrétaire | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | British | 160503520001 | ||||||
| PARKER, Shaun | Secrétaire | Whitley Bridge DN14 0HR Doncaster Whitley Lodge England | British | 185139590001 | ||||||
| SPARKES, Alan Patrick | Secrétaire | 16 Hartford Road B60 2HQ Bromsgrove Worcestershire | British | 14633060001 | ||||||
| WEBSTER, Richard Philip James | Secrétaire | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | British | 176640520001 | ||||||
| WHEELER, Robert Henry | Secrétaire | Lane Head Partridge Hill SG7 5QZ Ashwell Hertfordshire | British | 84817480001 | ||||||
| ATTWELL, Simon John | Administrateur | Appletree House Newton Road YO61 1QX Tollerton York | British | 41138740002 | ||||||
| BALDWIN, Gil Talbot | Administrateur | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | England | British | 117773400001 | |||||
| BUCKLEY, James Peter | Administrateur | The Park Swanland HU14 3UL North Ferribly Hollins East Yorkshire | England | British | 129550040002 | |||||
| DAWSON, Michael John | Administrateur | The Doctors House Askham Bryan YO2 3QS York North Yorkshire | British | 46372330001 | ||||||
| DUFFY, Neil Anthony | Administrateur | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | England | British | 89484760003 | |||||
| DYSON, Kevin Frederick | Administrateur | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | United Kingdom | British | 82727030001 | |||||
| ELSWORTHY, Stuart | Administrateur | Woodnorton Farmhouse Woodnorton WR11 4TE Evesham Worcestershire | United Kingdom | British | 19091640001 | |||||
| HAWKER, Michael James | Administrateur | Manor Croft 45 Lady Byron Lane Knowle B93 9AX Solihull West Midlands | England | British | 10686160001 | |||||
| JOHNSON, Duncan Miles | Administrateur | 20 Erwood Close B97 5XD Redditch Worcestershire | England | British | 34686140001 | |||||
| LOUGHLIN GERRARD, Wynne | Administrateur | 43 Cherrington Close Matchborough East B98 0BB Redditch Worcs | British | 28172420001 | ||||||
| LOWE, Jonathan Christopher | Administrateur | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | United Kingdom | British | 164709400001 | |||||
| MATTHEWS, Graham John | Administrateur | 13 Warwick Close Sheriff Hutton YO6 1QW York North Yorkshire | British | 63183330002 | ||||||
| MCINTIER, Brian William | Administrateur | 102 Halfway Street DA15 8DB Sidcup Kent | British | 27136400001 | ||||||
| PEARSON, Martin | Administrateur | Chapel Manor Browney Lane Browney DH7 8HU Durham | British | 43406530001 | ||||||
| RALPH, George Alexander | Administrateur | Great North Road Eaton Ford PE19 7FP St. Neots 367 Cambridgeshire | England | British | 184012200001 | |||||
| RICE, William Anthony | Administrateur | Briarfields Cranleigh Chase The Common GU6 8SH Cranleigh Surrey | England | British | 55752930001 | |||||
| SMITH, Stephen Leslie | Administrateur | 29 Herrilings Tickhill DN11 Doncaster | British | 55590670001 | ||||||
| SPARKES, Alan Patrick | Administrateur | 16 Hartford Road B60 2HQ Bromsgrove Worcestershire | British | 14633060001 | ||||||
| WEBSTER, Richard Philip James | Administrateur | Whitley Lodge Whitley Bridge DN14 0HR Yorkshire | England | British | 176633400001 | |||||
| WHEELER, Robert Henry | Administrateur | Lane Head Partridge Hill SG7 5QZ Ashwell Hertfordshire | British | 84817480001 | ||||||
| WINGARD, Peter | Administrateur | 34 St Matthews Close WR11 6ES Evesham Worcestershire | British | 30526280001 |
TUNSTALL VITALCALL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 16 nov. 1999 Livré le 29 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee as security trustee on its own behalf and for and on behalf of the beneficiaries (as defined) under the finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of accession (made 16TH june 1998 made between (1) the company and (2) national westminster bank PLC (the "security trustee") and (3) tedco PLC ("tedco") (the "accession deed")) to a composite guarantee and mortgage debenture (made 18TH may 1998 between (1) tedco and (2) the security trustee (the "debenture")) | Créé le 16 juin 1998 Livré le 25 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys, obligations and liabilities for the time being due, owing or incurred by the company to the chargee or any of them on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 10 avr. 1984 Livré le 19 avr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all book and other debts owed the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0