TUNSTALL VITALCALL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTUNSTALL VITALCALL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01687626
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MODERN VITALCALL LIMITED08 févr. 198808 févr. 1988
    AEROSPACE COMMUNICATION SYSTEMS LIMITED24 juin 198524 juin 1985

    Quels sont les derniers comptes de TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    5 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 sept. 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2015

    État du capital au 02 mars 2015

    • Capital: GBP 1,100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Shaun Parker en tant que secrétaire le 04 sept. 2014

    2 pagesTM02

    Nomination de Jonathan Paul Furniss en tant que secrétaire le 04 sept. 2014

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 févr. 2014

    État du capital au 24 févr. 2014

    • Capital: GBP 1,100,000
    SH01

    Nomination de Shaun Parker en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Webster en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Mr Shaun Parker en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Webster en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Paul Lancelot Stobart en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gil Baldwin en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kevin Dyson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin Dyson en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Richard Philip James Webster en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Richard Philip James Webster en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de TUNSTALL VITALCALL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FURNISS, Jonathan Paul
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Doncaster
    Whitley Lodge
    Yorkshire
    Secrétaire
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Doncaster
    Whitley Lodge
    Yorkshire
    British191128080001
    PARKER, Shaun
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Doncaster
    Whitley Lodge
    West Yorkshire
    Administrateur
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Doncaster
    Whitley Lodge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish100048680001
    STOBART, Paul Lancelot
    Doncaster Road
    DN14 0HR Whitley Bridge
    Whitley Lodge
    Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Doncaster Road
    DN14 0HR Whitley Bridge
    Whitley Lodge
    Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish175694060001
    ATTWELL, Simon John
    Appletree House
    Newton Road
    YO61 1QX Tollerton
    York
    Secrétaire
    Appletree House
    Newton Road
    YO61 1QX Tollerton
    York
    British41138740002
    DUFFY, Neil Anthony
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Secrétaire
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    British89484760003
    DYSON, Kevin Frederick
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Secrétaire
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    British160503520001
    PARKER, Shaun
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Doncaster
    Whitley Lodge
    England
    Secrétaire
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Doncaster
    Whitley Lodge
    England
    British185139590001
    SPARKES, Alan Patrick
    16 Hartford Road
    B60 2HQ Bromsgrove
    Worcestershire
    Secrétaire
    16 Hartford Road
    B60 2HQ Bromsgrove
    Worcestershire
    British14633060001
    WEBSTER, Richard Philip James
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Secrétaire
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    British176640520001
    WHEELER, Robert Henry
    Lane Head
    Partridge Hill
    SG7 5QZ Ashwell
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Lane Head
    Partridge Hill
    SG7 5QZ Ashwell
    Hertfordshire
    British84817480001
    ATTWELL, Simon John
    Appletree House
    Newton Road
    YO61 1QX Tollerton
    York
    Administrateur
    Appletree House
    Newton Road
    YO61 1QX Tollerton
    York
    British41138740002
    BALDWIN, Gil Talbot
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Administrateur
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    EnglandBritish117773400001
    BUCKLEY, James Peter
    The Park
    Swanland
    HU14 3UL North Ferribly
    Hollins
    East Yorkshire
    Administrateur
    The Park
    Swanland
    HU14 3UL North Ferribly
    Hollins
    East Yorkshire
    EnglandBritish129550040002
    DAWSON, Michael John
    The Doctors House
    Askham Bryan
    YO2 3QS York
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Doctors House
    Askham Bryan
    YO2 3QS York
    North Yorkshire
    British46372330001
    DUFFY, Neil Anthony
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Administrateur
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    EnglandBritish89484760003
    DYSON, Kevin Frederick
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Administrateur
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    United KingdomBritish82727030001
    ELSWORTHY, Stuart
    Woodnorton Farmhouse
    Woodnorton
    WR11 4TE Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Woodnorton Farmhouse
    Woodnorton
    WR11 4TE Evesham
    Worcestershire
    United KingdomBritish19091640001
    HAWKER, Michael James
    Manor Croft 45 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Manor Croft 45 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9AX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish10686160001
    JOHNSON, Duncan Miles
    20 Erwood Close
    B97 5XD Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    20 Erwood Close
    B97 5XD Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritish34686140001
    LOUGHLIN GERRARD, Wynne
    43 Cherrington Close
    Matchborough East
    B98 0BB Redditch
    Worcs
    Administrateur
    43 Cherrington Close
    Matchborough East
    B98 0BB Redditch
    Worcs
    British28172420001
    LOWE, Jonathan Christopher
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Administrateur
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    United KingdomBritish164709400001
    MATTHEWS, Graham John
    13 Warwick Close
    Sheriff Hutton
    YO6 1QW York
    North Yorkshire
    Administrateur
    13 Warwick Close
    Sheriff Hutton
    YO6 1QW York
    North Yorkshire
    British63183330002
    MCINTIER, Brian William
    102 Halfway Street
    DA15 8DB Sidcup
    Kent
    Administrateur
    102 Halfway Street
    DA15 8DB Sidcup
    Kent
    British27136400001
    PEARSON, Martin
    Chapel Manor Browney Lane
    Browney
    DH7 8HU Durham
    Administrateur
    Chapel Manor Browney Lane
    Browney
    DH7 8HU Durham
    British43406530001
    RALPH, George Alexander
    Great North Road
    Eaton Ford
    PE19 7FP St. Neots
    367
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Great North Road
    Eaton Ford
    PE19 7FP St. Neots
    367
    Cambridgeshire
    EnglandBritish184012200001
    RICE, William Anthony
    Briarfields Cranleigh Chase
    The Common
    GU6 8SH Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Briarfields Cranleigh Chase
    The Common
    GU6 8SH Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish55752930001
    SMITH, Stephen Leslie
    29 Herrilings
    Tickhill
    DN11 Doncaster
    Administrateur
    29 Herrilings
    Tickhill
    DN11 Doncaster
    British55590670001
    SPARKES, Alan Patrick
    16 Hartford Road
    B60 2HQ Bromsgrove
    Worcestershire
    Administrateur
    16 Hartford Road
    B60 2HQ Bromsgrove
    Worcestershire
    British14633060001
    WEBSTER, Richard Philip James
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    Administrateur
    Whitley Lodge
    Whitley Bridge
    DN14 0HR Yorkshire
    EnglandBritish176633400001
    WHEELER, Robert Henry
    Lane Head
    Partridge Hill
    SG7 5QZ Ashwell
    Hertfordshire
    Administrateur
    Lane Head
    Partridge Hill
    SG7 5QZ Ashwell
    Hertfordshire
    British84817480001
    WINGARD, Peter
    34 St Matthews Close
    WR11 6ES Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    34 St Matthews Close
    WR11 6ES Evesham
    Worcestershire
    British30526280001

    TUNSTALL VITALCALL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 nov. 1999
    Livré le 29 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee as security trustee on its own behalf and for and on behalf of the beneficiaries (as defined) under the finance documents and the mezzanine finance documents (both as defined
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of accession (made 16TH june 1998 made between (1) the company and (2) national westminster bank PLC (the "security trustee") and (3) tedco PLC ("tedco") (the "accession deed")) to a composite guarantee and mortgage debenture (made 18TH may 1998 between (1) tedco and (2) the security trustee (the "debenture"))
    Créé le 16 juin 1998
    Livré le 25 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys, obligations and liabilities for the time being due, owing or incurred by the company to the chargee or any of them on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 10 avr. 1984
    Livré le 19 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book and other debts owed the company. Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1984Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0