STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01689558 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED ?
Adresse du siège social | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 26 sept. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 sept. 2020 | 13 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Denise Patricia Burton en tant que secrétaire le 07 sept. 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gregory Joseph Mcmahon en tant que secrétaire le 07 sept. 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gregory Joseph Mcmahon en tant que secrétaire le 01 avr. 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Denise Patricia Burton en tant que secrétaire le 31 mars 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2019 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 29 sept. 2018 | 15 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 18 sept. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2017 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 24 sept. 2016 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 26 sept. 2015 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURTON, Denise Patricia | Secrétaire | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | 274005520001 | |||||||
BERROW, Jacqueline Ann | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | United Kingdom | British | Director | 154392330001 | ||||
JOHN, Gary | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | United Kingdom | British | Director | 174302530001 | ||||
THOMAS, Mark David | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | United Kingdom | British | Director | 174301010001 | ||||
VAUGHAN, Andrew William | Administrateur | Fleet Street B3 1JP Birmingham 27 West Midlands | United Kingdom | British | Director | 97486630001 | ||||
BENJAMIN, Rachel Abigail | Secrétaire | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | British | Chartered Secretary | 121622270001 | |||||
BROWN, Fiona Mary | Secrétaire | Hillocks Farm Kniveton DE6 1JH Ashbourne Derbyshire | British | 24112770001 | ||||||
BURTON, Denise Patricia | Secrétaire | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | 157144160001 | |||||||
MCMAHON, Gregory Joseph | Secrétaire | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | 268627300001 | |||||||
PENRICE, Victoria Margaret | Secrétaire | Trebartha 51a Frances Road SL4 3AQ Windsor Berkshire | British | Chartered Secretary | 90459300001 | |||||
SWITHENBANK, Mark Simon | Secrétaire | 25 Naseby Drive Long Eaton NG10 1PG Nottingham | British | Accountant | 47595030001 | |||||
TROUSDALE, Carolyn | Secrétaire | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | 155709190001 | |||||||
TWOMLOW, David John | Secrétaire | Manor Rise WS14 9RF Lichfield 44 Staffordshire | British | 50893390001 | ||||||
ALLEN, John Richard | Administrateur | Whispers Bakers Lane Westborough NG23 5HL Newark Nottinghamshire | British | Chartered Surveyor | 9931840001 | |||||
BALL, Hugh Lawrence | Administrateur | 11 Charles Street HP4 3DG Berkhamsted Herts | British | Chartered Surveyor | 26457040002 | |||||
BOLTER, Andrew Christopher | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | United Kingdom | British | Director | 146583270001 | ||||
BUTTERFIELD, John Christopher Noel Robert Hay | Administrateur | 3 Althorp Road SW17 7ED London | British | Director Of Strategy | 86367860001 | |||||
COX, Andrew Js | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | United Kingdom | British | None | 146779370001 | ||||
DARLEY, Shaun James | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | England | British | Director | 106878880002 | ||||
HOPSON, Stephen Robert | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | United Kingdom | British | Director | 166940230001 | ||||
LONGDEN, John David | Administrateur | Vicarage House Nidd HG3 3BN Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 40890250001 | ||||
NAFFAH, Karim | Administrateur | 75 Finlay Street SW6 6HF London | United Kingdom | British | Business Director | 61392390001 | ||||
PHILLIPS, Anthony Pugh | Administrateur | Lightbounds Wood Lane ST14 8BE Uttoxeter Staffordshire | British | Dir Of It And Property | 49047110001 | |||||
SMITH, Peter Francis | Administrateur | Meadow House Main Street East Keswick LS17 9EJ Leeds Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 2423840001 | ||||
SYKES, Adam Jeremy | Administrateur | 36 Swan Road WS13 6TU Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | Accountant | 26566820001 | ||||
THOMAS, Paul | Administrateur | 26 Risegate NG12 3JF Cotgrave Nottinghamshire | British | Chartered Accountant | 29218800001 | |||||
THOMPSON, Michael Robert | Administrateur | Park Road Alrewas DE13 7AG Burton On Trent 20 Staffordshire | British | Chartered Accountant | 134817070001 | |||||
TOLLEY, Paul Arthur | Administrateur | 26 Binswood Avenue CV32 5SQ Leamington Spa Warwickshire | England | British | Surveyor | 38413400002 | ||||
TOWNSEND, Jeremy Charles Douglas | Administrateur | 27 Fleet Street Birmingham B3 1JP West Midlands | England | British | Company Director | 106408890001 | ||||
WHEATON, Alison Thompson | Administrateur | 12 Highfield Mews South Hampstead NW6 3GB London | British | Portfolio Director | 90637280001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Commercial Property Developments Limited | 06 avr. 2016 | Fleet Street B3 1JP Birmingham 27 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
STANDARD COMMERCIAL PROPERTY SECURITIES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A standard security dated 29TH september 1999 which was presented for registration in scotland on 26TH october 1999 | Créé le 26 oct. 1999 Livré le 06 nov. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Property k/a 2ND ans 3RD or attic floors above the ground floor at 3 bath street/221 buchanan street glasgow abd the 3RD or attic floor above the ground floor at 209/217 buchanan street glasgow together with the whole rights. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 janv. 1994 Livré le 02 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,450,000 due from the company to the chargees under the terms of the charge | |
Brèves mentions Land at monks cross huntingdon york north yorkshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 29 juil. 1993 Livré le 05 août 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage all that f/h land at industrial park malton road york t/n NYK61351 ( the "monks cross property" ) and first legal mortgage the real property being:- back georgiana street west bury, unit 1 harbour quay wood wharf isle of dogs london, site F9 marsh wall millharbour road london E14. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 10 oct. 1990 Livré le 20 oct. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement of even date. | |
Brèves mentions F/H land at industrial park malton road title no nyk 61351. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0