JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01689995 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 30 nov. 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2017 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 224 pages | PARENT_ACC | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 25 oct. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que directeur le 31 mai 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited en tant qu'administrateur le 31 mai 2017 | 2 pages | AP02 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Matthew Egan en tant qu'administrateur le 31 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2017 | 2 pages | AP04 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 11 mai 2016
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven David Showell en tant que directeur le 04 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
| EGAN, Matthew | Administrateur | Oxford Street Ramsbury SN8 2PS Marlborough 35 United Kingdom | United Kingdom | British | 232755050001 | |||||||||
| SMITH, Neil Colin | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 204358750001 | |||||||||
| VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Secrétaire | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||||||
| BOLTON, Jonathan Mark | Secrétaire | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | 15931960005 | ||||||||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Secrétaire | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||||||
| DAVIDSON, Lorraine | Secrétaire | 18b Denver Road N16 5JH London | British | 103543780001 | ||||||||||
| DROLET, Robert | Secrétaire | 30 Lincoln Avenue Wimbledon SW19 5JT London | Canadian | 48244660002 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Secrétaire | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Secrétaire | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Secrétaire | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | 152569550001 | |||||||||||
| RUSSELL, Gary Peter | Secrétaire | 9 Pirton Close AL4 9YJ St Albans Hertfordshire | British | 44428050001 | ||||||||||
| STOCKMAN, Richard Graham | Secrétaire | 3 Albert Street AL1 1RT St Albans Hertfordshire | British | 7490950001 | ||||||||||
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| BEVERIDGE, Robert James | Administrateur | 81 Kidmore Road Caversham RG4 7NQ Reading | United Kingdom | British | 62452090001 | |||||||||
| CLARKE, Gregory Allison | Administrateur | Pinehurst Friary Road SL5 9HD Ascot Berkshire | British | 143319900001 | ||||||||||
| CLAYDON, Kenneth Keith | Administrateur | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | 60709330001 | ||||||||||
| COLEBROOK, Richard John | Administrateur | 30 Prospect Lane AL5 2PL Harpenden Hertfordshire | England | United Kingdom | 2606430002 | |||||||||
| COOPER, Nicholas Ian | Administrateur | 26 Red Lion Square WC1R 4HQ London 3rd Floor | Uk | British | 122128470002 | |||||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Administrateur | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135958960001 | |||||||||
| DROLET, Robert | Administrateur | 30 Lincoln Avenue Wimbledon SW19 5JT London | Canadian | 48244660002 | ||||||||||
| FITZ, Joseph Daniel | Administrateur | 35 Aria House 5-15 Newton Street Covent Garden WC2B 5EN London | British | 70579740002 | ||||||||||
| GARARD, Andrew Sheldon | Administrateur | Waldegrave House 293 Waldegrave Road TW1 4SU Twickenham Middlesex | British | 69630190003 | ||||||||||
| GIBSON, Ian Jeffrey | Administrateur | Stanmore House 3 Silverdale Road RH15 0ED Burgess Hill West Sussex | England | British | 78528840005 | |||||||||
| HEWITT, Martin Robert | Administrateur | 46 Milliners Court Lattimore Road AL1 3XT St. Albans Hertfordshire | British | 2606450004 | ||||||||||
| HOGGARTH, Royston | Administrateur | The Barley House Hawks Meadow Snowford Hall Farm CV33 9ES Hunningham Warwickshire | England | British | 67927330001 | |||||||||
| JAMES, Kevin | Administrateur | 6 Maxwell Close WD3 2BR Rickmansworth Hertfordshire | British | 55357740001 | ||||||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Administrateur | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | 108268030003 | |||||||||
| KINCH, Alan Royston | Administrateur | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | English | 163334420001 | |||||||||
| LERWILL, Robert Earl | Administrateur | Water Street WC2R 3LA London 1 | British | 51239200003 | ||||||||||
| MOLYNEUX, Mary Bridget | Administrateur | 33 Saint Jamess Gardens W11 4RF London | Australian | 63615470001 | ||||||||||
| NORTON, Graham Howard | Administrateur | Storrs Hill Cottage White Rose Lane GU22 7LB Woking Surrey | British | 91014890001 | ||||||||||
| PHILLIP, Kerry | Administrateur | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 185033430001 | |||||||||
| QUINN, Peter Herbert | Administrateur | Dog House HP5 1UQ Latimer Buckinghamshire | British | 663570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable & Wireless U.K. | 06 avr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Créé le 29 avr. 2002 Livré le 07 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the tenant (as defined therein) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The interest in the account a seperate designated interest bearing deposit account where the deposited sum of £211,712 is placed together with all monies including interest and other accruals standing to the credit of the said account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 01 mars 1996 Livré le 11 mars 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 60082953. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 08 févr. 1993 Livré le 11 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti £19,839.47 | |
Brèves mentions All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Credit agreement | Créé le 13 févr. 1991 Livré le 02 févr. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti £19290.36 | |
Brèves mentions All the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance particulars of which are set out on form M395 reference M338 c. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattles mortgage | Créé le 04 juin 1990 Livré le 06 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions One used jaguar 'e' type coupe. Registeration no jag 164L, chassis no. 1551428BW. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 17 janv. 1986 Livré le 29 janv. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 27 juin 1985 Livré le 04 juil. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges ovr the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts a legal mortgage over l/h property k/a the limies, 32/34 upper marlborough road, st albans, hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0