JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01689995
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JAGUAR COMMUNICATIONS PLC24 avr. 200824 avr. 2008
    EASYBROOK LIMITED07 janv. 198307 janv. 1983

    Quels sont les derniers comptes de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 nov. 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 14/11/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2017

    16 pagesAA

    legacy

    224 pagesPARENT_ACC

    Déclaration de confirmation établie le 25 oct. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    2 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Cessation de la nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que directeur le 31 mai 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited en tant qu'administrateur le 31 mai 2017

    2 pagesAP02

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 pagesAD04

    Cessation de la nomination de Vodafone Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Matthew Egan en tant qu'administrateur le 31 mai 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited en tant que secrétaire le 31 mai 2017

    2 pagesAP04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 11 mai 2016

    • Capital: GBP 1,000
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 22/04/2016
    RES13

    Cessation de la nomination de Steven David Showell en tant que directeur le 04 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2303594
    232519770001
    EGAN, Matthew
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    Administrateur
    Oxford Street
    Ramsbury
    SN8 2PS Marlborough
    35
    United Kingdom
    United KingdomBritish232755050001
    SMITH, Neil Colin
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish204358750001
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2303594
    232519770001
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    BOLTON, Jonathan Mark
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    Secrétaire
    22 Winchester Drive
    HA5 1DB Pinner
    Middlesex
    British15931960005
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Secrétaire
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    DAVIDSON, Lorraine
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    Secrétaire
    18b Denver Road
    N16 5JH London
    British103543780001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Secrétaire
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secrétaire
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secrétaire
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152569550001
    RUSSELL, Gary Peter
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    9 Pirton Close
    AL4 9YJ St Albans
    Hertfordshire
    British44428050001
    STOCKMAN, Richard Graham
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Albert Street
    AL1 1RT St Albans
    Hertfordshire
    British7490950001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2357692
    75473330004
    BEVERIDGE, Robert James
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    Administrateur
    81 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7NQ Reading
    United KingdomBritish62452090001
    CLARKE, Gregory Allison
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Pinehurst
    Friary Road
    SL5 9HD Ascot
    Berkshire
    British143319900001
    CLAYDON, Kenneth Keith
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    Administrateur
    1 Parr House
    12 Beaulieu Avenue
    E16 1TS London
    British60709330001
    COLEBROOK, Richard John
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    30 Prospect Lane
    AL5 2PL Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandUnited Kingdom2606430002
    COOPER, Nicholas Ian
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    Administrateur
    26 Red Lion Square
    WC1R 4HQ London
    3rd Floor
    UkBritish122128470002
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    DROLET, Robert
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Administrateur
    30 Lincoln Avenue
    Wimbledon
    SW19 5JT London
    Canadian48244660002
    FITZ, Joseph Daniel
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    Administrateur
    35 Aria House
    5-15 Newton Street Covent Garden
    WC2B 5EN London
    British70579740002
    GARARD, Andrew Sheldon
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Waldegrave House
    293 Waldegrave Road
    TW1 4SU Twickenham
    Middlesex
    British69630190003
    GIBSON, Ian Jeffrey
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Stanmore House
    3 Silverdale Road
    RH15 0ED Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish78528840005
    HEWITT, Martin Robert
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    46 Milliners Court
    Lattimore Road
    AL1 3XT St. Albans
    Hertfordshire
    British2606450004
    HOGGARTH, Royston
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    Administrateur
    The Barley House
    Hawks Meadow Snowford Hall Farm
    CV33 9ES Hunningham
    Warwickshire
    EnglandBritish67927330001
    JAMES, Kevin
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    6 Maxwell Close
    WD3 2BR Rickmansworth
    Hertfordshire
    British55357740001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    Administrateur
    25 Chiswick Quay
    W4 3UR London
    EnglandBritish108268030003
    KINCH, Alan Royston
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomEnglish163334420001
    LERWILL, Robert Earl
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    Administrateur
    Water Street
    WC2R 3LA London
    1
    British51239200003
    MOLYNEUX, Mary Bridget
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Administrateur
    33 Saint Jamess Gardens
    W11 4RF London
    Australian63615470001
    NORTON, Graham Howard
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    Administrateur
    Storrs Hill Cottage
    White Rose Lane
    GU22 7LB Woking
    Surrey
    British91014890001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Administrateur
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    QUINN, Peter Herbert
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Dog House
    HP5 1UQ Latimer
    Buckinghamshire
    British663570001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueUnlimited With Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1541957
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    JAGUAR COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 29 avr. 2002
    Livré le 07 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the tenant (as defined therein) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The interest in the account a seperate designated interest bearing deposit account where the deposited sum of £211,712 is placed together with all monies including interest and other accruals standing to the credit of the said account.
    Personnes ayant droit
    • Euroinvest Estates Limited
    Transactions
    • 07 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 01 mars 1996
    Livré le 11 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all the deposits together with all interest in account no 60082953. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Credit agreement
    Créé le 08 févr. 1993
    Livré le 11 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19,839.47
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 11 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Credit agreement
    Créé le 13 févr. 1991
    Livré le 02 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19290.36
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance particulars of which are set out on form M395 reference M338 c.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 02 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattles mortgage
    Créé le 04 juin 1990
    Livré le 06 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One used jaguar 'e' type coupe. Registeration no jag 164L, chassis no. 1551428BW.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 06 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 janv. 1986
    Livré le 29 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See doc M17). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 27 juin 1985
    Livré le 04 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges ovr the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts a legal mortgage over l/h property k/a the limies, 32/34 upper marlborough road, st albans, hertfordshire and/or the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0