COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE)
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | 01690026 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) ?
| Adresse du siège social | 6 Hays Lane SE1 2HB London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Nomination de Mr Simon Jeffery Hutson en tant qu'administrateur le 09 févr. 2026 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Johnson en tant que directeur le 09 févr. 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr John Michael Balean en tant qu'administrateur le 01 janv. 2026 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Neil Jonathan Burgess en tant que directeur le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 1 st. Katharines Way London E1W 1UN England à 6 Hays Lane London SE1 2HB | 1 pages | AD02 | ||
Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 mars 2025 | 30 pages | AA | ||
Nomination de Mr Anthony Johnson en tant qu'administrateur le 01 juil. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Matthew James Pfleger en tant que directeur le 22 juil. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Edwin Matthew Thomas en tant qu'administrateur le 01 juin 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Ms Monisha Shah en tant qu'administrateur le 01 juin 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Rosemary Pema Glazebrook en tant que directeur le 31 mai 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de James Redvers Mcconnachie en tant que directeur le 30 avr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Chun Kit Fan en tant qu'administrateur le 01 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Thomas Edward Francis Chatfield en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 35 Ballards Lane London N3 1XW England à 6 Hays Lane London SE1 2HB le 16 déc. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Philip Majurey en tant que directeur le 31 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 mars 2024 | 30 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Serena Dederding en tant que secrétaire le 16 sept. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Mark Walford en tant qu'administrateur le 01 sept. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 35 pages | AA | ||
Nomination de Mr Okechukwu Ndubisi Nzelu en tant qu'administrateur le 01 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Eve Joanne Revill en tant que directeur le 28 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDERDING, Serena | Secrétaire | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | 327280940001 | |||||||
| BALEAN, John Michael | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 203181400001 | |||||
| FAN, Chun Kit, Dr | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 309949580001 | |||||
| FREEMAN, Andrew Robert | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 290364910001 | |||||
| FREEMAN, Jackie Doreen | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 307504280001 | |||||
| HUTSON, Simon Jeffery | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | United Kingdom | British | 179070050003 | |||||
| NZELU, Okechukwu Ndubisi | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 314294560001 | |||||
| SHAH, Monisha | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 322994210002 | |||||
| THOMAS, Edwin Matthew | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 211069700001 | |||||
| VOSS, Susan | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 255474540001 | |||||
| WALFORD, Mark | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 310368850001 | |||||
| WARD QUINN, Catherine | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | United Kingdom | British | 274864700001 | |||||
| DELANEY, Martin | Secrétaire | Saffron House 6-10 Kirby Street EC1N 8TS London | British | 121950050001 | ||||||
| HADLEY, Colin Philip | Secrétaire | Yeomans Cottage Marsh Green EX5 2EX Exeter Devon | British | 21590690001 | ||||||
| SHEPHERD, Peter Francis | Secrétaire | 117a Springvale Road Kingsworthy SO23 7LE Winchester Hampshire | British | 53854080002 | ||||||
| BARLAS, Christopher Richard | Administrateur | 25 Hartland Road NW1 8DB London | British | 5805140001 | ||||||
| BIDE, Mark | Administrateur | Hay's Galleria 4 Battle Bridge Lane SE1 2HX London Shackleton House England | England | British | 75049000006 | |||||
| BIRD, Faye | Administrateur | Ballards Lane N3 1XW London 35 England | England | British | 237952510001 | |||||
| BRADLEY, Thomas Fredrick | Administrateur | Saffron House 6-10 Kirby Street EC1N 8TS London | England | British | 44770290012 | |||||
| BRADMAN, Tony John | Administrateur | Ballards Lane N3 1XW London 35 England | England | British | 118847960001 | |||||
| BRADMAN, Tony John | Administrateur | 29 The Heights Foxgrove Road BR3 5BY Beckenham Kent | England | British | 118847960001 | |||||
| BURGESS, Neil Jonathan | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 34127700002 | |||||
| CHATFIELD, Thomas Edward Francis, Dr | Administrateur | Hays Lane SE1 2HB London 6 England | England | British | 232604060001 | |||||
| CLARK, Charles | Administrateur | 19 Offley Road SW9 0LR London | British | 5101800001 | ||||||
| COLE, Gerald Anthony | Administrateur | Nima Dappers Lane, Angmering BN16 4EN Littlehampton West Sussex | British | 36246670002 | ||||||
| COLLINS, Christopher John | Administrateur | Akhurst Farm Hawthorn Lane Four Marks GU34 5AU Alton Hampshire | England | British | 95070420001 | |||||
| DAVIES, John Roderick Mervyn | Administrateur | 47 Manor Park Road Finchley N2 0SN London | British | 8994550001 | ||||||
| DEARLING, Alan | Administrateur | 45 Haymons Cove TD14 5EG Eyemouth Berwickshire | Scotland | British | 118847930001 | |||||
| DONOVAN, Bernard Thomas, Professor | Administrateur | 48 Kelsey Lane BR3 3NE Beckenham Kent | British | 29367970001 | ||||||
| DORNER, Jane | Administrateur | 9 Collingwood Avenue N10 3EH London | United Kingdom | British | 141162590001 | |||||
| DUFFY, Maureen Patricia | Administrateur | 18 Fabian Road SW6 7TZ London | British | 21279790001 | ||||||
| EVANS, James Matthew Alexander Clark | Administrateur | Saffron House 6-10 Kirby Street EC1N 8TS London | England | British | 151976400001 | |||||
| FABER, Tobias William | Administrateur | 86 Fetter Lane EC4A 1EN London Barnard's Inn England | England | British | 85283600001 | |||||
| FITZGERALD, Kevin Jeffrey | Administrateur | Saffron House 6-10 Kirby Street EC1N 8TS London | England | British | 111501560001 | |||||
| GABRIEL, Juri Evald | Administrateur | 35 Camberwell Grove SE5 8JA London | United Kingdom | British | 21590720001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publishers' Licensing Services Limited | 06 avr. 2016 | St. Katharines Way E1W 1UN London 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Authors' Licensing And Collecting Society Limited | 06 avr. 2016 | St. Katharines Way E1W 1UN London 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour COPYRIGHT LICENSING AGENCY LIMITED(THE) ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 29 nov. 2016 | 29 nov. 2016 | La société a envoyé une notification conformément à l'article 790D de la loi qui n'a pas été respectée. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0