BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED

BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01698320
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Priestley Centre
    10 Priestley Road
    The Surrey Research Park,
    Guildford, Surrey Gu27xy
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED01 oct. 199001 oct. 1990
    AIRCO BVT COATING TECHNOLOGY LIMITED24 juil. 198924 juil. 1989
    BVT LIMITED12 déc. 198312 déc. 1983
    BARONSAND LIMITED10 févr. 198310 févr. 1983

    Quels sont les derniers comptes de BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Modification des coordonnées du secrétaire Susan Kathleen Kelly le 01 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 14 oct. 2009

    • Capital: GBP 4,813,987.87
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    7 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Statuts

    11 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed airco coating technology LIMITED\certificate issued on 17/09/09
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    5 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KELLY, Susan Kathleen
    10 Priestley Road, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    Secrétaire
    10 Priestley Road, The Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    British71087960003
    BRACKFIELD, Andrew Christopher
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor118706260003
    DENNIS, Michael
    Boc Limited
    Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Boc Limited
    Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishHead Of Marketing Uk & Ireland118951230001
    FINKEN, Thorben, Dr
    10 Priestley Road
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    Administrateur
    10 Priestley Road
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    EnglandGermanFinance Director-Boc Uk & Irel152685750001
    BRACKFIELD, Andrew Christopher
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishSolicitor118706260003
    HUNT, Carol Anne
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Secrétaire
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishChartered Secretary40992870003
    LARKINS, Sarah Louise
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    Secrétaire
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    BritishChartered Secretary99307280001
    PAVEY, David Gordon
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    British3878440002
    BAKER, Ian Kenneth Hood
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    33 Atfield Grove
    GU20 6DP Windlesham
    Surrey
    BritishCs3994580001
    DEEMING, Nicholas
    The Boc Group Plc
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    The Boc Group Plc
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    British64399320009
    GRUBB, Albany Delma
    640 Castle Rock Road
    Walnut Creek
    California 94598
    Usa
    Administrateur
    640 Castle Rock Road
    Walnut Creek
    California 94598
    Usa
    AmericanPresident-Airco Coating Technology33081330001
    HUNT, Carol Anne
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    The Boc Group
    Chertsey Road
    GU20 6HJ Windlesham
    Surrey
    BritishChartered Secretary40992870003
    LARKINS, Sarah Louise
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    Administrateur
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    BritishChartered Secretary99307280001
    LEWIS, Nigel Andrew
    The Linde Group The Priestley
    Centre 10 Priestley Rd The Surrey, Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group The Priestley
    Centre 10 Priestley Rd The Surrey, Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector Acquisitions & New Vent146324340001
    LLOYD, Caroline Mary
    The Little House
    Knightons Lane, Dunsfold
    GU8 4NU Godalming
    Surrey
    Administrateur
    The Little House
    Knightons Lane, Dunsfold
    GU8 4NU Godalming
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor79670850001
    MOBERLY, Andrew John
    64 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    64 St Marks Road
    RG9 1LW Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishSolicitor62717630001
    MOSTYN, Gareth
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishAccountant126699160001
    PAVEY, David Gordon
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    28 Malthouse Close
    Church Crookham
    GU13 0TB Fleet
    Hampshire
    BritishCs3878440002
    PREBBLE, John Mark Selwyn
    Carbery Mount Pleasant
    Hartley Wintney
    RG27 8PW Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Carbery Mount Pleasant
    Hartley Wintney
    RG27 8PW Basingstoke
    Hampshire
    British/New ZealanderLawyer75270780001
    ROSENKRANZ, Franklin Daniel
    Windrush
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston-Upon-Thames
    Surrey
    Administrateur
    Windrush
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston-Upon-Thames
    Surrey
    United KingdomBritishManaging Director3878460001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    EnglandBritishAssistant Secretary67168210001
    SPENCE, Patrick Charles Gordon
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road
    GU2 7XY Surrey Research Park
    Surrey
    Administrateur
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road
    GU2 7XY Surrey Research Park
    Surrey
    BritishChartered Accountant79853340013
    STRADLING, Roderick Saffin
    5075 Valley Crest Drive, No 244
    94521 Concord
    California
    Usa
    Administrateur
    5075 Valley Crest Drive, No 244
    94521 Concord
    California
    Usa
    BritishPresident-Airco Coating Technology56584520002
    WALSH, Thomas Brian
    30 Jacksons Edge Road
    Disley
    SK12 2JL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    30 Jacksons Edge Road
    Disley
    SK12 2JL Stockport
    Cheshire
    BritishManaging Director53153020001

    BOC AIRCO COATING TECHNOLOGY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 10 févr. 1988
    Livré le 10 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 10 févr. 1988
    Livré le 10 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 23 déc. 1986
    Livré le 07 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a deposit agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Baronsmead Associates Limited.
    Transactions
    • 07 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 23 déc. 1986
    Livré le 07 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a deposit agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Baronsmead Associates Limited.
    Transactions
    • 07 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Revoting fixed charge over cash deposits
    Créé le 30 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed term deposit account no 002126 any moneys nowar hereaftes standing to the credit of a desingnated account with lloyds bank PLC and all interest of the company therein and all interest now due or heanceforth to become due in respect thereof. The schedule the account at lloyds bank PLC designated "lloyds bank PLC re bvt LTD".
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    Revolving fixed charge over cash deposits
    Créé le 30 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed term deposit account no 002126 any moneys, now or hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC and all interest of the company therein and all interest now due or hence forth to become due in respect thereof the schedule the account at lloyds bank PLC designated lloyds bank PLC re bvt LTD.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    A series of variable date secured loan notes
    Créé le 12 juin 1986
    Livré le 18 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Transactions
    • 18 juin 1986Enregistrement d'une charge
    A series of variable date secured loan notes
    Créé le 12 juin 1986
    Livré le 18 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Transactions
    • 18 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 02 janv. 1985
    Livré le 07 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any moneys now or hereafter standing to the credit of any account of the company with lloyds bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 02 janv. 1985
    Livré le 07 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any moneys now or hereafter standing to the credit of and account of the company with lloyds bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 mai 1984
    Livré le 04 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stocks, shares & other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1984Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 02 mai 1984
    Livré le 04 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All stocks shares & other securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1984Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0