NEW CRANE WHARF LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEW CRANE WHARF LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01708589
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEW CRANE WHARF LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe NEW CRANE WHARF LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fisher Partners Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEW CRANE WHARF LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONRAN ROCHE DEVELOPMENTS LIMITED22 mars 198322 mars 1983

    Quels sont les derniers comptes de NEW CRANE WHARF LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NEW CRANE WHARF LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NEW CRANE WHARF LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    État du capital au 07 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Reduce share capital a/c 24/03/2014
    RES14

    Changement d'adresse du siège social de Heron House 4 Bentinck Street London W1U 2EF United Kingdom le 28 mars 2014

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Jonathan Simon Goldstein en tant que directeur le 31 déc. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Daniel Simon Samson en tant qu'administrateur le 31 déc. 2013

    2 pagesAP01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Lionel Harvey Zeltser le 27 sept. 2010

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Simon Goldstein le 27 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Heron House 19 Marylebone Road London NW1 5JL le 04 oct. 2010

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de NEW CRANE WHARF LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ZELTSER, Lionel Harvey
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Secrétaire
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    British82318190001
    RONSON, Gerald Maurice, Sir
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritish33068600002
    SAMSON, Daniel Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    EnglandBritish183982890001
    BROWN, Steven Andrew
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    Secrétaire
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    British107162240001
    FENCHELLE, Mark Stephen
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    Secrétaire
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    British40682770001
    MORTON, Christopher John
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    Secrétaire
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    British71879280001
    PARSONS, Neil
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    Secrétaire
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    British67799270001
    ROBERTSON, Ian Donald Winton
    Ashley Gate 17 Ashley Park Road
    KT12 1JN Walton On Thames
    Surrey
    Secrétaire
    Ashley Gate 17 Ashley Park Road
    KT12 1JN Walton On Thames
    Surrey
    British35557760001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish8958700001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish8958700001
    GOLDSTEIN, Jonathan Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritish68352140004
    KITCHEN, Daniel John
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    United KingdomBritish153028260001
    LEWIS, Peter George Henry
    Mulberry House High Street
    Iron Acton
    BS17 1UQ Bristol
    Avon
    Administrateur
    Mulberry House High Street
    Iron Acton
    BS17 1UQ Bristol
    Avon
    British4783680001
    MARX, Michael Henry
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Orchard California Lane
    WD23 1ES Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish35019090001
    WATTS, Robert Alan
    19 Uplands Road
    West Moors
    BH22 0BB Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    19 Uplands Road
    West Moors
    BH22 0BB Ferndown
    Dorset
    British28646160001

    NEW CRANE WHARF LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limitedas Trustee on Behalf of the Secured Parties
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alnery No. 1283 Limited
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as ssc trustee on behalf of the secured parties under the terms of this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1993
    Livré le 08 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee on behalf of the secured parties under the terms of this charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 1987
    Livré le 14 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the guarantee and the facility letter of even date and under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    The land at new crane wharf, wapping, london E1 title no egl 182287 and all buildings, fixtures and fittings. All future f/h & l/h property of the company together with all buildings, fixtures & fittings (including trade fixtures & fittings) & fixed plant & machinery, goodwill & uncalled capital and all bookdebts & other debts due or owing to the company.
    Personnes ayant droit
    • Heron Corporation PLC.
    Transactions
    • 14 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 14 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment & charge.
    Créé le 02 juil. 1987
    Livré le 14 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the project agreement of evendate
    Brèves mentions
    All moneys for the time being and from time to time standing to the credit of the proceeds account with lloyds bank PLC "(the bank)" numbered 1532044) (see form 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • Heron Homes Limited
    Transactions
    • 14 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 juil. 1987
    Livré le 09 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures) see form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Proceeds account assignment and charge.
    Créé le 02 juil. 1987
    Livré le 09 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 2/7/87.
    Brèves mentions
    All moneys for the time being and from time to time standing to the credit of the proceeds account with the bank numbered 1532044.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed
    Créé le 24 mars 1987
    Livré le 25 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee dated 15/8/86 & the facility letter dated 13/8/86
    Brèves mentions
    Land at new crane wharf & the three suns public house, wapping E1 title no:- egl 182287.
    Personnes ayant droit
    • Heron Corporation PLC
    Transactions
    • 25 mars 1987Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 15 août 1986
    Livré le 29 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at new crane wharf and the three suns public house wapping E1 title no's 168816, 300680 21358, ln 70267, ngl 312721, 245126.
    Personnes ayant droit
    • Heron Corporation PLC
    Transactions
    • 29 août 1986Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 15 août 1986
    Livré le 29 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/7/86
    Brèves mentions
    Land at new crane wharf and the three suns public house wapping E1 title no's 168816, 300680 21358, ln 70267, ngl 312721, 245126.
    Personnes ayant droit
    • Kestrel Properties Limited
    Transactions
    • 29 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 07 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NEW CRANE WHARF LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 mars 2014Commencement of winding up
    19 déc. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    practitioner
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0