X-CEL SUPERTURN LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéX-CEL SUPERTURN LTD
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01710788
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de X-CEL SUPERTURN LTD ?

    • fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (25990) / Industries manufacturières

    Où se situe X-CEL SUPERTURN LTD ?

    Adresse du siège social
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de X-CEL SUPERTURN LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    X-CEL SUPERTURN (GB) LIMITED22 oct. 200722 oct. 2007
    SHEFFIELD SUPERTURN LIMITED15 août 199015 août 1990
    NORTH DERBYSHIRE PRECISION ENGINEERING LIMITED30 mars 198330 mars 1983

    Quels sont les derniers comptes de X-CEL SUPERTURN LTD ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour X-CEL SUPERTURN LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 juin 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour X-CEL SUPERTURN LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Louis Wragg en tant qu'administrateur le 01 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    2 pagesMR04

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 17 juin 2020

    4 pagesRP04CS01

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    26 pagesAA

    Inscription de la charge 017107880019, créée le 08 nov. 2023

    13 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Mr Andrew Nicholas Taylor en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2022

    2 pagesPSC04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 017107880016 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 017107880017 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 017107880018, créée le 12 janv. 2021

    6 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2020 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    24 sept. 2024Clarification A second filed CS01 (Statement of Capital and Shareholder Information) was registered on 24/09/2024

    Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2019

    37 pagesAA

    03/05/19 Statement of Capital gbp 2860.0

    7 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re-dividend/transfer 20/03/2019
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Issue of share 18/03/2019
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Subdivision des actions au 18 mars 2019

    4 pagesSH02

    Qui sont les dirigeants de X-CEL SUPERTURN LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FURNISS-PLANT, Leanne
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    Secrétaire
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    British187998370001
    BARTON-PHILLIPS, David
    Brindley Way
    R-Evolution @ The Amp
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3
    Administrateur
    Brindley Way
    R-Evolution @ The Amp
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3
    EnglandBritishNone194027990002
    FURNISS-PLANT, Leanne Tracey
    Brindley Way
    R-Evolution @ The Amp
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3
    Administrateur
    Brindley Way
    R-Evolution @ The Amp
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3
    EnglandBritishNone177743380003
    HERON, Tim Mark
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    Administrateur
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    EnglandBritishNone192376740001
    TAYLOR, Andrew Nicholas
    Geer Lane
    Ford
    S12 3YF Sheffield
    Birley Hay Farm
    Administrateur
    Geer Lane
    Ford
    S12 3YF Sheffield
    Birley Hay Farm
    EnglandBritishCompany Director & Engineer68227890003
    WATSON, Ben Grant
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    Administrateur
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    EnglandBritishNone178405150001
    WRAGG, Louis
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    Administrateur
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    EnglandBritishOperations Director332166130001
    TAYLOR, Andrew Nicholas
    Atlas Way
    Atlas North
    S4 7QQ Sheffield
    32
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Atlas Way
    Atlas North
    S4 7QQ Sheffield
    32
    South Yorkshire
    United Kingdom
    British68227890002
    TAYLOR, Jane
    Greenacre Grindlow
    Great Hucklow
    SK17 8RJ Buxton
    Derbyshire
    Secrétaire
    Greenacre Grindlow
    Great Hucklow
    SK17 8RJ Buxton
    Derbyshire
    British3421950001
    BURRELL, Mark Stephan
    Cumberworth Lane
    Cumberworth
    HD8 8YA Huddersfield
    Dearne Grange Barn
    West Yorkshire
    Administrateur
    Cumberworth Lane
    Cumberworth
    HD8 8YA Huddersfield
    Dearne Grange Barn
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director50882640003
    CRAMPIN, Joanne
    Aldam Chase
    Wickersley
    S66 1FR Rotherham
    4
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Aldam Chase
    Wickersley
    S66 1FR Rotherham
    4
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director135303180003
    HALL, Andrew James
    Oakfield Drive
    WF14 8PX Mirfield
    2
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Oakfield Drive
    WF14 8PX Mirfield
    2
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishEngineering111848970001
    HERON, Tim Mark
    Packman Way
    Wath Upon Dearne
    S63 6BR Rotherham
    40
    South Yorkshire
    Administrateur
    Packman Way
    Wath Upon Dearne
    S63 6BR Rotherham
    40
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director192376740001
    KIRK, James
    Millstone Works
    32 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Administrateur
    Millstone Works
    32 Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    EnglandBritishNone187998570001
    MARSH, John Michael
    39 Barkby Road
    Wincobank
    S9 1JX Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    39 Barkby Road
    Wincobank
    S9 1JX Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishWorks Director41653830001
    NUGENT, Christopher James Dennison
    Aiton House
    133a High Street
    DN14 5PJ Hook
    South Yorkshire
    Administrateur
    Aiton House
    133a High Street
    DN14 5PJ Hook
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector65473130003
    SHARPLES, Andrew John
    Zorbit Mews
    SK14 4GN Hyde
    18
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Zorbit Mews
    SK14 4GN Hyde
    18
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishNone126933880001
    TAYLOR, Jane
    Greenacre Grindlow
    Great Hucklow
    SK17 8RJ Buxton
    Derbyshire
    Administrateur
    Greenacre Grindlow
    Great Hucklow
    SK17 8RJ Buxton
    Derbyshire
    BritishCompany Director3421950001
    WATSON, Ben Grant
    Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Sheffield
    9
    S Yorks
    England
    Administrateur
    Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Sheffield
    9
    S Yorks
    England
    EnglandBritishNone178405150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur X-CEL SUPERTURN LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Andrew Nicholas Taylor
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    06 avr. 2016
    Brindley Way
    S60 5FS Rotherham
    Unit 3 R-Evolution@Amp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    X-CEL SUPERTURN LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 08 nov. 2023
    Livré le 10 nov. 2023
    En cours
    Brève description
    A legal assignment of contract monies.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 12 janv. 2021
    Livré le 13 janv. 2021
    En cours
    Brève description
    A legal mortgage over the freehold property known as newburgh house centurion business park bessemer way rotherham registered at h m land registry with title number SYK489550.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 mars 2019
    Livré le 18 mars 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold property known as unit 3, r-evolution at the amp, brindley way, catcliffe rotherham, registered at h m land registry with title number SYK625864.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 déc. 2018
    Livré le 11 déc. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Freehold property known as land adjacent to unit 3 brindley way, catcliffe, rotherham, south yorkshire.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC ("the Bank")
    Transactions
    • 11 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 20 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 22 avr. 2014
    Livré le 24 avr. 2014
    En cours
    Brève description
    None.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2013
    Livré le 17 déc. 2013
    En cours
    Brève description
    Assignment. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 17 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 juil. 2013
    Livré le 25 juil. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transactions
    • 25 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal mortgage
    Créé le 27 mars 2012
    Livré le 30 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a millstone works 32 atlas way sheffield t/no SYK380265 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 09 oct. 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 27 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 20 nov. 2006
    Livré le 25 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a millstone works, 32 atlas way, sheffield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 13 juil. 2006
    Livré le 27 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 27 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 13 juil. 2006
    Livré le 21 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all the plant and machinery vehicles computers and other equipment listed in the schedule to form 395 inclusive of victor ow cnc lathe; victor tns-2H cnc lathe; victor v-16 cnc lathe (for details of further chattels charged please refer to form 395) and all spare parts replacements modifications and additions for or to the same and the full benefit of all warranties and maintenance contracts in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 21 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 févr. 2001
    Livré le 17 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as unit 16 nutwood trading estate limestone cottage lane wadsley bridge sheffield S6 t/no: SYK276191.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 24 févr. 2000
    Livré le 09 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transactions
    • 09 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First fixed and floating charge
    Créé le 24 févr. 2000
    Livré le 29 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book and other debts under an agreement dated 24TH february 00 floating charge on all proceeds of book and other debts under or in connection with any agreement or contract for the sale and purchase of debts or under or in connection with any bill of exchange or other negotiable instrument. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transactions
    • 29 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 mai 1998
    Livré le 19 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H part unit 1 nutwood trading estate limestone cottage lane wadsley bridge sheffield south yorkshire t/n SYK263485 SYK304873 SYK307914. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 déc. 1995
    Livré le 20 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 17 nutwood trading estate limestone cottage lane wadsley bridge sheffield south yorkshire t/no SYK292102 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 nov. 1995
    Livré le 17 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 30 mars 1989
    Livré le 07 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 18, nutwood trading estate, limestone cottage lane, wadsley bridge, sheffield, south yorkshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0