KEMBREY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | KEMBREY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01713322 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KEMBREY LIMITED ?
| Adresse du siège social | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KEMBREY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour KEMBREY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
État du capital au 27 nov. 2020
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 oct. 2019 | 10 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 144 pages | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2018 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Flowers en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2016 | 9 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Gregory Lewis en tant qu'administrateur le 19 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 03 janv. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Bowers en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael James Flowers le 13 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de KEMBREY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLARD, Sarah Louise | Secrétaire | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | 43855640011 | ||||||
| ELLARD, Sarah Louise | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 43855640013 | |||||
| LEWIS, Andrew Gregory | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | 222848510001 | |||||
| EDGE, Geoffrey | Secrétaire | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Secrétaire | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||
| VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Secrétaire | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | 3801050001 | ||||||
| BERLANNY, Brian Peter | Administrateur | 3 Portsdown Avenue Drayton PO6 1EH Portsmouth Hampshire | British | 3825330001 | ||||||
| BILLINGTON, Philip Gordon | Administrateur | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | 18247670001 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| BURNET, David Stewart | Administrateur | Westland Farm Ockley Road Ewhurst GU6 7SL Cranleigh Surrey | Australian | 5918230001 | ||||||
| BURNS, Robert Ernest | Administrateur | 20 Tennyson Road CV37 7JU Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 1525660001 | ||||||
| CLEARY, Michael John | Administrateur | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | 1525670001 | ||||||
| EVANS, David Roger | Administrateur | 28 St Ronans Avenue PO4 0QE Southsea Hampshire | British | 4471420001 | ||||||
| FLOWERS, Michael James | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 188873370002 | |||||
| GIBBS, Raymond John | Administrateur | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | 85421380001 | ||||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Administrateur | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | United Kingdom | British | 42841660001 | |||||
| PAPWORTH, Mark Harry | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 103085690002 | |||||
| PRICE, David John | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| RAYNER, Paul Adrian | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| WHITEHORN, Justin Michael | Administrateur | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 42825970001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KEMBREY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemring Group Plc | 30 juin 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
KEMBREY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Créé le 29 avr. 1993 Livré le 06 mai 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 sept. 1990 Livré le 09 oct. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 20 mars 1990 Livré le 26 mars 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of charge | Créé le 09 août 1989 Livré le 24 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneis due or to become due from sarclad investments limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of an accounts of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 oct. 1983 Livré le 12 oct. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0