ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED

ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01713670
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALBEMARLE & BOND PAWNBROKERS LIMITED08 juin 198808 juin 1988
    ALBEMARLE PAWNBROKERS LIMITED18 févr. 198818 févr. 1988
    ALBEMARLE & BOND PAWNBROKERS LIMITED04 sept. 198604 sept. 1986
    ALBEMARLE PAWNBROKERS LIMITED24 nov. 198324 nov. 1983
    DIGPOND LIMITED11 avr. 198311 avr. 1983

    Quels sont les derniers comptes de ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 22 sept. 2016

    15 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 26 juil. 2016

    14 pages2.24B

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 26

    8 pagesMR05

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 26 janv. 2016

    15 pages2.24B

    Démission d'un administrateur

    1 pages2.38B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 26 juil. 2015

    15 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 01 mars 2015

    18 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 24 sept. 2014

    20 pages2.24B

    Cessation de la nomination de Nygel Scourfield en tant que directeur le 01 août 2014

    2 pagesTM01

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    11 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    24 pages2.17B

    Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 26

    11 pagesMR05

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor 2 Burgage Square Merchant Gate Wakefield WF1 2TS* le 29 avr. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de Paula Watts en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    29 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 nov. 2013

    État du capital au 15 nov. 2013

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Satisfaction de la charge 21 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORAN, Liam Kevin
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    County House
    17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd Floor
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer149505190001
    ARMOUR, Douglas William
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    170354660001
    FLANAGAN, Michael Anthony
    7a Hamilton Road
    Ealing
    W5 2EE London
    Secrétaire
    7a Hamilton Road
    Ealing
    W5 2EE London
    Irish34791200003
    WALLACE, Susan Margaret
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    British95024880001
    WATTS, Paula Mary
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    2 Burgage Square Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd
    United Kingdom
    174916620001
    DAMARIO, Lynda
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Administrateur
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    United KingdomBritishJeweller76785710002
    MARDON TAYLOR, Nicholas John
    6 Millers Court Chiswick Mall
    W4 2PF London
    Administrateur
    6 Millers Court Chiswick Mall
    W4 2PF London
    EnglandBritishChartered Accountant105294260003
    MURPHY, Jean Louise
    1 Monmouth Road
    Bishopston
    BS7 8LF Bristol
    Administrateur
    1 Monmouth Road
    Bishopston
    BS7 8LF Bristol
    BritishCompany Administrator55811680001
    MURPHY, Philip Patrick
    53 Pooles Wharf Court
    Hotwells
    BS8 4PB Bristol
    Avon
    Administrateur
    53 Pooles Wharf Court
    Hotwells
    BS8 4PB Bristol
    Avon
    BritishPawnbroker21524180003
    NICHOLLS, Greville Vincent
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    Administrateur
    Portwall Lane
    BS1 6NA Bristol
    Portwall Place
    United KingdomBritishChartered Accountant51899820004
    PAGE, David Alistair Louden
    19 Harwell Road
    Sutton Courtenay
    OX14 4BN Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    19 Harwell Road
    Sutton Courtenay
    OX14 4BN Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritishOperational Director173283710001
    PATTINSON, David Phillip
    23 Blewbury Road
    OX11 9LE East Hagbourne
    Oxfordshire
    Administrateur
    23 Blewbury Road
    OX11 9LE East Hagbourne
    Oxfordshire
    United KingdomNew ZealandAccountant76785870001
    SCOURFIELD, Nygel Paul
    Floor
    County House 17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    County House 17 Friar Street
    RG1 1DB Reading
    2nd
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director - Operations164256290001
    STEVENSON, Barry John
    2 Burgage Square
    Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Burgage Square
    Merchant Gate
    WF1 2TS Wakefield
    2nd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director102595670001

    ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent security deposit deed
    Créé le 18 mars 2013
    Livré le 27 mars 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All interest in the deposit account (initial deposit of £1,833.33) and all money from time to time withdrawn from the deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clerical Medical Investment Group Limited
    Transactions
    • 27 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 août 2012
    Livré le 11 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All interest in the amount from time to time standing to the credit of the separate bearing deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Arshad Mohammed
    Transactions
    • 11 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2011
    Livré le 25 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights,all plant machinery vehicles computers,office and other equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Parties
    Transactions
    • 25 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 avr. 2014Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 05 mai 2016Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    Rent security deposit deed
    Créé le 26 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clerical Medical Investment Group Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 3RD november 2000 and
    Créé le 17 juil. 2007
    Livré le 25 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 07 avr. 2004
    Livré le 08 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 603 cheetham hill road cheetham hill manchester t/n GM742678. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 20 mars 2001
    Livré le 22 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7 and 9 havelock street blythe. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 20 mars 2001
    Livré le 22 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    122 rushey green catford london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage deed
    Créé le 03 nov. 2000
    Livré le 22 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being 13/15 east street bedminster bristol. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 sept. 2000
    Livré le 28 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 oct. 1996
    Livré le 12 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any agreement the debenture and the guarantee
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Brown Shipley & Co Limited
    Transactions
    • 12 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 févr. 1996
    Livré le 10 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 13 east street bedminster bristol t/no. AV68953 and all buildings and fixtures and goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 21 avr. 1994
    Livré le 27 avr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Lease
    Créé le 22 déc. 1993
    Livré le 24 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 22 december 1993
    Brèves mentions
    The sum of £5,000 plus interest thereon in the event that there is a claim under the lease or any sum owing under the lease which sum is to be deposited by the mortgagee with barclays bank PLC or such other clearing bank as the mortgagee shall nominate.
    Personnes ayant droit
    • Ilmaquil Investments Limited
    Transactions
    • 24 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 08 juil. 1991
    Livré le 10 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the facility letter dated 8/7/91
    Brèves mentions
    Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Central Europe Corporation Sa
    Transactions
    • 10 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 06 févr. 1991
    Livré le 16 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An amount of up to sterling pounds 50000 due or to become due from the company to the chargee under a loan facility of even date and any other sums due thereunder
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • J S Gadd Holdings Limited
    Transactions
    • 16 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 mars 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 mars 1988
    Livré le 16 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises situate at & k/a 124 city road, cardiff south glamorgan t/n wa 253035 & others (please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Fennoscandia Bank Limited
    Transactions
    • 16 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 avr. 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 1988
    Livré le 16 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and premises situate at & k/a 124 city road, cardiff south glamorgan t/n wa 253035 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including buildings fixtures fixed plant and machinery (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Fennoscandia Bank Limited
    Transactions
    • 16 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 avr. 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 nov. 1987
    Livré le 25 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1030 stockport road levenshulme manchester. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Henry Ausbacher & Co Limited
    Transactions
    • 25 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 nov. 1987
    Livré le 09 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1030 stockport road, levenshulme manchester greater manchester t/n p 199565.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 13 juil. 1987
    Livré le 22 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transactions
    • 22 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 22 juin 1987
    Livré le 07 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    274 shirley road, southampton, hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 08 avr. 1987
    Livré le 23 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 13 oct. 1986
    Livré le 27 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    124, city road, roath, cardiff, south glamorgan. T/n :- wa 253035.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 13 oct. 1986
    Livré le 27 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    15, east street, bedminster, bristol t/n:- av 48213.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 1986Enregistrement d'une charge

    ALBEMARLE & BOND JEWELLERS & PAWNBROKERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 sept. 2016Administration ended
    25 mars 2014Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Toby Scott Underwood
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    practitioner
    101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Stuart David Maddison
    One Reading Central
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    practitioner
    One Reading Central
    23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter David Dickens
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0