COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED

COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01718450
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WARMOCTAVE LIMITED26 avr. 198326 avr. 1983

    Quels sont les derniers comptes de COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 févr. 2012

    État du capital au 15 févr. 2012

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ian Richardson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Story en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Martin Keith Tyler en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Graham Story le 06 oct. 2010

    4 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Stuart Richardson le 23 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jeremy Peter Small le 23 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secrétaire
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    British135642970001
    TYLER, Martin Keith
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Great BritainBritishChartered Accountant158372390001
    COX, John Ashley
    The Birche
    Shelsley Beauchamp
    WR6 6RD Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    The Birche
    Shelsley Beauchamp
    WR6 6RD Worcester
    Worcestershire
    British7337090002
    THANANGADAN, Verghese Elias
    105 Cornwallis Road
    Bilton
    CV22 7SJ Rugby
    Warwickshire
    Secrétaire
    105 Cornwallis Road
    Bilton
    CV22 7SJ Rugby
    Warwickshire
    British66178960001
    ALLEN, Raymond Stephen Leonard
    11 Rushton Close
    Balsall Common
    CV7 7PA Coventry
    Administrateur
    11 Rushton Close
    Balsall Common
    CV7 7PA Coventry
    EnglandBritishInsurance Broker9555640001
    BLACKHAM, Christopher Layton
    1 Manor Farm
    Church End, Leckhampstead
    MK18 5NU Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Manor Farm
    Church End, Leckhampstead
    MK18 5NU Buckingham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishInsurance Broker66178820001
    BRADFORD, Geoffrey Charles
    8 East Sheen Avenue
    SW14 8AS London
    Administrateur
    8 East Sheen Avenue
    SW14 8AS London
    EnglandBritishCompany Director50021630001
    COX, John Ashley
    The Birche
    Shelsley Beauchamp
    WR6 6RD Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    The Birche
    Shelsley Beauchamp
    WR6 6RD Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritishInsurance Broker7337090002
    DENNISTON, Nicholas Geoffrey Alastair
    40a Ladbroke Square
    W11 3ND London
    Administrateur
    40a Ladbroke Square
    W11 3ND London
    EnglandBritishFinance Director92602370001
    GLAZZARD, Stewart
    4 White Castle
    WR4 0RA Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    4 White Castle
    WR4 0RA Worcester
    Worcestershire
    BritishInsurance Broker67704500001
    MEREDITH, Andrew John
    12 Hop Pole Green
    Leigh Sinton
    WR13 5DP Malvern
    Worcestershire
    Administrateur
    12 Hop Pole Green
    Leigh Sinton
    WR13 5DP Malvern
    Worcestershire
    BritishInsurance Broker25562170002
    NEEDHAM, Leonard Matthew
    Norgrove
    Hanley Childe
    WR15 8QY Tenbury Wells
    Worcestershire
    Administrateur
    Norgrove
    Hanley Childe
    WR15 8QY Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishInsurance Broker25562180001
    RICHARDSON, Ian Stuart
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    UkBritishCompany Director79822370002
    STORY, Ian Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritishCompany Director75238840004
    THANANGADAN, Verghese Elias
    105 Cornwallis Road
    Bilton
    CV22 7SJ Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    105 Cornwallis Road
    Bilton
    CV22 7SJ Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Secretary66178960001

    COX, HEPBURN (INSURANCE SERVICES) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 28 mars 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2001
    Livré le 09 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 juil. 1991
    Livré le 09 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 31 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 oct. 1987
    Livré le 02 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0