INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01719390 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED ?
| Adresse du siège social | Vicon House 2 Western Way IP33 3SP Bury St. Edmunds Suffolk England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 28 déc. 2023
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Victor Reed en tant que directeur le 07 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 10 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Edward Evans en tant qu'administrateur le 25 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Laura Clare Ryan en tant que secrétaire le 25 mai 2022 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 44 Loman Street London SE1 0EH England à Vicon House 2 Western Way Bury St. Edmunds Suffolk IP33 3SP le 10 juin 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy Charles Waud en tant que directeur le 25 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2021 | 15 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 4 - 6 Dudley Road Tunbridge Wells Kent TN1 1LF à 44 Loman Street London SE1 0EH le 11 juin 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Kevin Dunkley en tant que secrétaire le 01 avr. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Laura Anne Phillips en tant que directeur le 01 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Laura Anne Phillips en tant qu'administrateur le 01 avr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Kevin Dunkley en tant que secrétaire le 01 avr. 2021 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Vivian Athey en tant que secrétaire le 01 avr. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAN, Laura Clare | Secrétaire | Heath Farm Business Centre, Tut Hill Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Servest House Suffolk England | 296915810001 | |||||||
| EVANS, Thomas Edward | Administrateur | Heath Farm Business Centre, Tut Hill Fornham All Saints IP28 6LG Bury St. Edmunds Servest House Suffolk England | England | British | 289303810001 | |||||
| ATHEY, Martin Vivian | Secrétaire | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent England | 166937270001 | |||||||
| DUNKLEY, Paul Kevin | Secrétaire | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent | 281572320001 | |||||||
| WETHERELL, Mary Elizabeth | Secrétaire | 4th Floor 100 Christian Street E1 1RS London | British | 33772470003 | ||||||
| DEAN, Conrad George | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent | United Kingdom | British | 241226100001 | |||||
| DUNKLEY, Paul Kevin | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent England | England | British | 147804180002 | |||||
| MORRISON, Simon Brian | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent | England | British | 250864590001 | |||||
| NOBLE, Ian Corsar | Administrateur | Bellew Street SW17 0AD London 8 | England | British | 123063290001 | |||||
| PHILLIPS, Laura Anne | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent | England | British | 281572940001 | |||||
| PICKARD, Craig Thomas | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent England | England | Canadian | 43311720002 | |||||
| POLLARD, William Thomas | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent England | United Kingdom | British | 166936430001 | |||||
| PRADHAN, Rajeev | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent England | England | British | 107504060002 | |||||
| REED, Martin Victor | Administrateur | 2 Western Way IP33 3SP Bury St. Edmunds Vicon House Suffolk England | England | British | 119487800001 | |||||
| SEBIRE, David John | Administrateur | Mill Farm Wood Lane BS37 6PG Horton Bristol | United Kingdom | British | 146651840001 | |||||
| TAYLOR, Sara Elizabeth | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent | England | British | 237845250001 | |||||
| WAUD, Jeremy Charles | Administrateur | Loman Street SE1 0EH London 44 England | United Kingdom | British | 2436610003 | |||||
| WAUD, Stephen Gilbert | Administrateur | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 Kent | England | British | 2456790005 | |||||
| WETHERELL, Jeremy Walter Paxton | Administrateur | 4th Floor 100 Christian Street E1 1RS London | British | 33772460003 | ||||||
| WETHERELL, Mary Elizabeth | Administrateur | 4th Floor 100 Christian Street E1 1RS London | England | British | 33772470003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incentive Fm Group Limited | 06 avr. 2016 | Dudley Road TN1 1LF Tunbridge Wells 4 - 6 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
INCENTIVE LYNX SECURITY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge | Créé le 17 mai 2012 Livré le 01 juin 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies and limited liability partnerships named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 01 janv. 2004 Livré le 03 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 26 août 1998 Livré le 10 sept. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0