FORECOURT PROPERTIES LIMITED

FORECOURT PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFORECOURT PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01723832
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FORECOURT PROPERTIES LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe FORECOURT PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FORECOURT PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JADEFUN LIMITED17 mai 198317 mai 1983

    Quels sont les derniers comptes de FORECOURT PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour FORECOURT PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2011

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2011

    État du capital au 14 juil. 2011

    • Capital: GBP 3,185,825
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    13 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2010 au 30 mars 2010

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Trafalgar Officers Limited le 22 juin 2010

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Reit(Corporate Services) Limited le 09 déc. 2009

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher George White le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice Moses Benady le 01 mai 2010

    3 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    15 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    4 pages288a

    Résolutions

    Resolutions
    8 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 175 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FORECOURT PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Secrétaire
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    Administrateur
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Administrateur
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6745658
    135316290001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Administrateur
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    FORECOURT PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2004
    Livré le 29 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 29 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 19 janv. 2000
    Livré le 31 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land k/a brimrod high street chalfont st peter and land k/a the grange garage high street chalfont st peter t/nos.BM171862 and BM2130. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 janv. 2000
    Livré le 20 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land k/a brimrod high street chalfont st peter and land k/a the grange garage high street chalfont st peter t/nos: BM171862 and BM2130. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mai 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Créé le 18 oct. 1999
    Livré le 23 oct. 1999
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 20 mars 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 mars 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Guarantee and mortgage debenture
    Créé le 04 août 1992
    Livré le 19 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein ) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 févr. 1992
    Livré le 24 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the 02 goodwill book and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 1988
    Livré le 06 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    197 high street uxbridge middlesex.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 janv. 1986
    Livré le 20 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a 6 chippendale waye, uxbridge, london borough of hillingdon. T/n: ngl 443478.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 1985
    Livré le 03 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 7 chippendale waye uxbridge middlesex t/n:- ngl 360288.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 mars 1985
    Livré le 26 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H propety k/a 8 chippendale waye uxbridge middlesex.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 mars 1984
    Livré le 13 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    214-218 high street uxbridge. 4-13 the square, uxbridge and land at the rear tog. With the land edged red on the plan annexed to a transfer dated 9/3/84. title nos:- ngl 229008, mx 79874, mx 95436, mx 223252, mx 113581, mx 270848, mx 108001.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1984Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 déc. 1983
    Livré le 23 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H - 207-211 high street uxbridge L.B. of hillingdon inc. Land at the rear thereof. Title nos:- mx 428528 mx 474398 mx 153714 ngl 118243.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    • 10 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0