HINCHLIFFE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHINCHLIFFE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01725267
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HINCHLIFFE LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe HINCHLIFFE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    75 Mosley Street
    M2 3HR Manchester
    Lancashire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HINCHLIFFE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EASTGATE PROPERTIES LIMITED16 févr. 198416 févr. 1984
    KENSALGRANGE LIMITED20 mai 198320 mai 1983

    Quels sont les derniers comptes de HINCHLIFFE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HINCHLIFFE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HINCHLIFFE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 déc. 2015

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 juin 2015

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 déc. 2014

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 juin 2014

    3 pages3.6

    Report de la dissolution

    1 pagesL64.04

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 déc. 2013

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 juin 2013

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 déc. 2012

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 juin 2012

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 déc. 2011

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 juin 2011

    3 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 03 déc. 2010

    3 pages3.6

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    legacy

    4 pagesLQ01

    Cessation de la nomination de Matthew Billington en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Nazlin Nawaz en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2009

    8 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2008

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 oct. 2008 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2007

    15 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de HINCHLIFFE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NAWAZ, Nazlin
    Mosley Street
    M2 3HR Manchester
    75
    Lancashire
    England
    Administrateur
    Mosley Street
    M2 3HR Manchester
    75
    Lancashire
    England
    United KingdomPakistani138897760001
    CHOWDERY, Nabeel Mussarat
    16 Langham Road
    Bowdon
    WA14 2HY Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    16 Langham Road
    Bowdon
    WA14 2HY Altrincham
    Cheshire
    British104669540002
    HINCHLIFFE, Jennifer Denise
    Tai-Pan Lote 65
    Caixa No 12
    Tapada De Penina
    8500 Portimao
    Portugal
    Secrétaire
    Tai-Pan Lote 65
    Caixa No 12
    Tapada De Penina
    8500 Portimao
    Portugal
    British23482470002
    PELHAM, David Anthony
    22 Longacres Road
    Halebarns
    WA15 0RS Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    22 Longacres Road
    Halebarns
    WA15 0RS Altrincham
    Cheshire
    British38856340001
    BILLINGTON, Matthew
    Moss Lane
    Hale
    WA15 8AN Altrincham
    136a
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Moss Lane
    Hale
    WA15 8AN Altrincham
    136a
    Cheshire
    United Kingdom
    British135210960001
    HINCHLIFFE, Christopher Elliott
    Tai-Pan Lote 65
    Caixa No 12
    Tapada De Penina
    8500 Portimao
    Portugal
    Administrateur
    Tai-Pan Lote 65
    Caixa No 12
    Tapada De Penina
    8500 Portimao
    Portugal
    British19870180002
    HINCHLIFFE, Jennifer Denise
    Tai-Pan Lote 65
    Caixa No 12
    Tapada De Penina
    8500 Portimao
    Portugal
    Administrateur
    Tai-Pan Lote 65
    Caixa No 12
    Tapada De Penina
    8500 Portimao
    Portugal
    British23482470002
    MUSSARAT CHOWDERY, Nabeel
    Apartment 5 Eastdale
    Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Apartment 5 Eastdale
    Hale
    WA15 0LX Altrincham
    Cheshire
    British123089510001
    ZOLGHADRIHA, Ali
    142 Chatsworth Road
    M28 2NT Worsley
    Lancashire
    Administrateur
    142 Chatsworth Road
    M28 2NT Worsley
    Lancashire
    British90933730002

    HINCHLIFFE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment of rent
    Créé le 21 juin 2007
    Livré le 28 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of mortgage all gross rents, licence fees and other monies receivable now or hereafter at any time by the company in respect of or arising out of any lease or licence of any property or any agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 28 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 20 juin 2007
    Livré le 28 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 28 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 nov. 2005
    Livré le 24 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in phoenix street oldham being part of brunswick court. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 24 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 sept. 2005
    Livré le 06 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The properties being unit 7 roman way business park droitwich t/n HW142808, unit 2 ten pound walk doncaster t/n SYK316878, 21 regent street barnsley t/n SYK33956, for details of further properties charged, please refer to form 395,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 06 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2005
    Livré le 06 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The properties being unit 7 roman way business park droitwich t/n HW142808, unit 2 ten pound walk doncaster t/n SYK316878, 21 regent street barnsley t/n SYK33956,for details of further properties charged, please refer to form 395,. and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 06 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 124 déc. 2009Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (LQ01)
      • Numéro de dossier 1
    Legal charge
    Créé le 26 juil. 2004
    Livré le 27 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 2 ten pound walk doncaster. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 juin 2004
    Livré le 01 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit A1 elm place eynsham oxfordshire OX8 1PU. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 mars 2003
    Livré le 12 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage units 4 & 5 st. James' court friargate derby. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 juil. 2002
    Livré le 12 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage unit 5 jephson court, tancred close, queensway, leamington spa, warwickshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 févr. 2002
    Livré le 25 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the property k/a unit 7, roman way business park, droitwich and parking spaces,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 août 2000
    Livré le 19 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at equinox 2 clifton park off shipton road york. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1999
    Livré le 01 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 6 pioneer business park clifton moorgate york. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1999
    Livré le 01 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    8 regent street barnsley south yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 août 1998
    Livré le 11 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Spitfire house amy johnson way clifton moorgate york. Together with all plant machinery fixtures and fittings, all furniture furnishings equipment tools and other chattels and goodwill and the proceeds of any insurance.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 août 1998
    Livré le 27 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h 21 regent street barnsley south yorkshire t/n-SYK33956.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 1995
    Livré le 02 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Elm place, five elms, eynsham, oxfordshire t/no.on 124440 and goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 mars 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 sept. 1993
    Livré le 16 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property known as or being unit h, meadow lane, st ives,cambridgeshire title no cb 106852.. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transactions
    • 16 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 avr. 1992
    Livré le 06 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a units 4 and 5 st james court friargate derby l/h carparking spaces lying to the rear and sides of units 4 and 5 st james court friargate derby. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1991
    Livré le 29 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Units a, b, & c, brunswick courts, oldham, greater manchester fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juin 1990
    Livré le 19 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land situate at and k/a 38 to 44 shambles street barnsly S.yorkshire title no syk 192630 together with movable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland.
    Transactions
    • 19 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 04 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1990
    Livré le 14 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H k/a 37-41 (odd) wellington street sheffield south yorkshire t/no syk 209413. fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1990
    Livré le 14 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All freehold land and buildings k/a 14 ship hill rotherham south yorkshire t/no syk 238961 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1990
    Livré le 14 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 26 clarendon street nottingham nottinghamshire t/no nt 27307. fixed charge over all movable plant machinery implements utensls furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1990
    Livré le 14 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 22 and 24 clarendon street nottingham nottinghamshire t/no nt 30586 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 févr. 1990
    Livré le 14 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 92-98 (even) queen street and 14-20 (even) pardise street and land adjoining sheffield south yorkshire t/no syk 275079 fixed carge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 déc. 1991Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 11 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HINCHLIFFE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Lindsey J Cooper
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Milton Keynes
    receiver manager
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Milton Keynes
    Graham Paul Bushby
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    receiver manager
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    2
    DateType
    30 avr. 2014Conclusion of winding up
    16 sept. 2009Petition date
    09 déc. 2009Commencement of winding up
    14 mars 2016Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    practitioner
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0