IMBERCOURT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | IMBERCOURT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01725422 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IMBERCOURT LIMITED ?
| Adresse du siège social | 100 Barbirolli Square M2 3EY Manchester |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IMBERCOURT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour IMBERCOURT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 7 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 sept. 2012 | 7 pages | 4.68 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6WG le 11 oct. 2011 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Moss le 15 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Merrick le 05 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de IMBERCOURT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 | 115204320002 | |||||||
| MERRICK, Michael John | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | England | British | 74114060001 | |||||
| MOSS, Andrew | Administrateur | Wythall Green Way Wythall B47 6WG Birmingham 1 England | United Kingdom | British | 151524430001 | |||||
| BERG, John Hilton | Secrétaire | Flat 1 Vicarage Court Holden Road N12 7DN London | British | 62158140001 | ||||||
| BRIERLEY, Heather Gwendolyn | Secrétaire | 5 Cygnets Close RH1 2QE Redhill Surrey | British | 72090290001 | ||||||
| EVES, Richard Anthony | Secrétaire | 20 Warley Rise Tilehurst RG31 6FR Reading Berkshire | British | 51097960001 | ||||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Secrétaire | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||
| JONES, Vanessa | Secrétaire | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||
| MILLER, Jan Victor | Secrétaire | 5 Robin Hill Drive Elmstead Woods BR7 5ER Chislehurst Kent | British | 31687720002 | ||||||
| WILLS, Eric Roland | Secrétaire | 2 Chestnut Avenue Southborough TN4 0BP Tunbridge Wells Kent | British | 484010001 | ||||||
| WILMAN, Jennifer Jane | Secrétaire | Turnberry House Northop Country Park Northop CH7 6WD Mold Clwyd | British | 100783210001 | ||||||
| YOUNG, Bernadette Clare | Secrétaire | 21 Kent View Avenue SS9 1HE Leigh On Sea Essex | British | 52675260002 | ||||||
| AUSTEN, Michael John | Administrateur | 2 Vale Croft Vale Road Claygate KT10 0NX Esher Surrey | British | 57998700001 | ||||||
| BUX, Iqbal | Administrateur | 25 Ormathwaites Corner RG12 6XX Warfield Berkshire | British | 36233270002 | ||||||
| CRAINE, Roger | Administrateur | 2 Pheasant Field Hale Village L24 5SD Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 89585440001 | |||||
| DOWNING, Wadham St John | Administrateur | Lilac Croft Pool Close Little Comberton WR10 3EL Pershore Worcestershire | United Kingdom | British | 107951950001 | |||||
| GREENFIELD, Richard Edward Keith | Administrateur | Byeways Neston CH64 7TA South Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 100783270001 | |||||
| GREENFIELD, Richard Edward Keith | Administrateur | Byeways Neston CH64 7TA South Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 100783270001 | |||||
| HANCE, Julian Christopher | Administrateur | 127 Western Road BN6 9SY Hurstpierpoint West Sussex | British | 40271690001 | ||||||
| HAYES, Thomas Arthur | Administrateur | Oak House Colchester Road CO7 7PH Ardleigh Essex | British | 813400005 | ||||||
| KAFETZ, David Robert | Administrateur | 12 Grange Road RH10 4JT Crawley Down West Sussex | British | 66850630001 | ||||||
| KEANE, John Joseph | Administrateur | 233 The Colonnades Albert Dock L3 4AB Liverpool Merseyside | Irish | 69495780002 | ||||||
| LUSCOMBE, Kerr | Administrateur | 3e Melbourne Court Braidpark Drive, Giffnock G46 6LA Glasgow | Scotland | British | 83541890001 | |||||
| MATTHEWS, Fiona | Administrateur | Bowling Alley Farm Commonside WA6 9HA Alvanly Cheshire | Uk | British | 143208680001 | |||||
| MEEHAN, Brendan Joseph | Administrateur | 24 Kirby Close NN4 6AB Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 98270380001 | |||||
| MILLER, David James | Administrateur | 100 Rosebery Avenue EC1R 4TL London | British | 12718430002 | ||||||
| MILLER, Jan Victor | Administrateur | 5 Robin Hill Drive Elmstead Woods BR7 5ER Chislehurst Kent | British | 31687720002 | ||||||
| NELSON, Thomas Scott | Administrateur | Ramblers 3 The Cricket Green Woodside Road GU8 4UG Chiddingfold Surrey | British | 39609060001 | ||||||
| O'BRIEN, Christopher David | Administrateur | 3 Ingle Green Blundellsands L23 6XY Liverpool | British | 58150100001 | ||||||
| PARRY, David Ronald | Administrateur | The Pines 18 Baskervyle Road Gayton L60 8NL Wirral Merseyside | British | 9450150001 | ||||||
| PATER, George Stephan | Administrateur | 11 Leighton Court Neston CH64 6UW South Wirral | British | 50723060001 | ||||||
| SCOTT-LEE, James Richard | Administrateur | Little Green Brill HP18 9SF Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 9430340001 | |||||
| SIMPSON, Ian Donald | Administrateur | Bohemia House Harpsden Way RG9 1NX Henley Oxfordshire | England | British | 105493630001 | |||||
| STOCKTON, Robert Paul | Administrateur | Leek Wootton House Warwick Road, Leek Wootton CV35 7QR Warwick | England | British | 120520560001 | |||||
| WINCH, Ronald Horace William | Administrateur | 20 Hildred House 80 Ebury Mews SW1 London | Australian | 35787260001 |
IMBERCOURT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Letter of set off | Créé le 14 nov. 1984 Livré le 28 nov. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to teh chargee | |
Brèves mentions All the property referred in the deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of sef-off | Créé le 19 oct. 1983 Livré le 27 oct. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brèves mentions Credit balances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 18 juil. 1983 Livré le 22 juil. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book & other debts uncalled capital, together with fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
IMBERCOURT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0