IMBERCOURT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIMBERCOURT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01725422
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IMBERCOURT LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe IMBERCOURT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IMBERCOURT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BECKETTS LIMITED17 déc. 199217 déc. 1992
    AGENCY ESTATE INVESTMENTS LIMITED23 mai 198323 mai 1983

    Quels sont les derniers comptes de IMBERCOURT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour IMBERCOURT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 sept. 2012

    7 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 1 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6WG le 11 oct. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 sept. 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2010

    État du capital au 28 oct. 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Moss le 15 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Merrick le 05 mars 2010

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de IMBERCOURT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Secrétaire
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    115204320002
    MERRICK, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish74114060001
    MOSS, Andrew
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish151524430001
    BERG, John Hilton
    Flat 1 Vicarage Court
    Holden Road
    N12 7DN London
    Secrétaire
    Flat 1 Vicarage Court
    Holden Road
    N12 7DN London
    British62158140001
    BRIERLEY, Heather Gwendolyn
    5 Cygnets Close
    RH1 2QE Redhill
    Surrey
    Secrétaire
    5 Cygnets Close
    RH1 2QE Redhill
    Surrey
    British72090290001
    EVES, Richard Anthony
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    20 Warley Rise
    Tilehurst
    RG31 6FR Reading
    Berkshire
    British51097960001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Secrétaire
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    MILLER, Jan Victor
    5 Robin Hill Drive
    Elmstead Woods
    BR7 5ER Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    5 Robin Hill Drive
    Elmstead Woods
    BR7 5ER Chislehurst
    Kent
    British31687720002
    WILLS, Eric Roland
    2 Chestnut Avenue
    Southborough
    TN4 0BP Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    2 Chestnut Avenue
    Southborough
    TN4 0BP Tunbridge Wells
    Kent
    British484010001
    WILMAN, Jennifer Jane
    Turnberry House
    Northop Country Park Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    Secrétaire
    Turnberry House
    Northop Country Park Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    British100783210001
    YOUNG, Bernadette Clare
    21 Kent View Avenue
    SS9 1HE Leigh On Sea
    Essex
    Secrétaire
    21 Kent View Avenue
    SS9 1HE Leigh On Sea
    Essex
    British52675260002
    AUSTEN, Michael John
    2 Vale Croft Vale Road
    Claygate
    KT10 0NX Esher
    Surrey
    Administrateur
    2 Vale Croft Vale Road
    Claygate
    KT10 0NX Esher
    Surrey
    British57998700001
    BUX, Iqbal
    25 Ormathwaites Corner
    RG12 6XX Warfield
    Berkshire
    Administrateur
    25 Ormathwaites Corner
    RG12 6XX Warfield
    Berkshire
    British36233270002
    CRAINE, Roger
    2 Pheasant Field
    Hale Village
    L24 5SD Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    2 Pheasant Field
    Hale Village
    L24 5SD Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish89585440001
    DOWNING, Wadham St John
    Lilac Croft
    Pool Close Little Comberton
    WR10 3EL Pershore
    Worcestershire
    Administrateur
    Lilac Croft
    Pool Close Little Comberton
    WR10 3EL Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritish107951950001
    GREENFIELD, Richard Edward Keith
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish100783270001
    GREENFIELD, Richard Edward Keith
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    Byeways
    Neston
    CH64 7TA South Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish100783270001
    HANCE, Julian Christopher
    127 Western Road
    BN6 9SY Hurstpierpoint
    West Sussex
    Administrateur
    127 Western Road
    BN6 9SY Hurstpierpoint
    West Sussex
    British40271690001
    HAYES, Thomas Arthur
    Oak House
    Colchester Road
    CO7 7PH Ardleigh
    Essex
    Administrateur
    Oak House
    Colchester Road
    CO7 7PH Ardleigh
    Essex
    British813400005
    KAFETZ, David Robert
    12 Grange Road
    RH10 4JT Crawley Down
    West Sussex
    Administrateur
    12 Grange Road
    RH10 4JT Crawley Down
    West Sussex
    British66850630001
    KEANE, John Joseph
    233 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    233 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    Merseyside
    Irish69495780002
    LUSCOMBE, Kerr
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    Administrateur
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    ScotlandBritish83541890001
    MATTHEWS, Fiona
    Bowling Alley Farm
    Commonside
    WA6 9HA Alvanly
    Cheshire
    Administrateur
    Bowling Alley Farm
    Commonside
    WA6 9HA Alvanly
    Cheshire
    UkBritish143208680001
    MEEHAN, Brendan Joseph
    24 Kirby Close
    NN4 6AB Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    24 Kirby Close
    NN4 6AB Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish98270380001
    MILLER, David James
    100 Rosebery Avenue
    EC1R 4TL London
    Administrateur
    100 Rosebery Avenue
    EC1R 4TL London
    British12718430002
    MILLER, Jan Victor
    5 Robin Hill Drive
    Elmstead Woods
    BR7 5ER Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    5 Robin Hill Drive
    Elmstead Woods
    BR7 5ER Chislehurst
    Kent
    British31687720002
    NELSON, Thomas Scott
    Ramblers 3 The Cricket Green
    Woodside Road
    GU8 4UG Chiddingfold
    Surrey
    Administrateur
    Ramblers 3 The Cricket Green
    Woodside Road
    GU8 4UG Chiddingfold
    Surrey
    British39609060001
    O'BRIEN, Christopher David
    3 Ingle Green
    Blundellsands
    L23 6XY Liverpool
    Administrateur
    3 Ingle Green
    Blundellsands
    L23 6XY Liverpool
    British58150100001
    PARRY, David Ronald
    The Pines 18 Baskervyle Road
    Gayton
    L60 8NL Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    The Pines 18 Baskervyle Road
    Gayton
    L60 8NL Wirral
    Merseyside
    British9450150001
    PATER, George Stephan
    11 Leighton Court
    Neston
    CH64 6UW South Wirral
    Administrateur
    11 Leighton Court
    Neston
    CH64 6UW South Wirral
    British50723060001
    SCOTT-LEE, James Richard
    Little Green
    Brill
    HP18 9SF Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Green
    Brill
    HP18 9SF Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish9430340001
    SIMPSON, Ian Donald
    Bohemia House
    Harpsden Way
    RG9 1NX Henley
    Oxfordshire
    Administrateur
    Bohemia House
    Harpsden Way
    RG9 1NX Henley
    Oxfordshire
    EnglandBritish105493630001
    STOCKTON, Robert Paul
    Leek Wootton House
    Warwick Road, Leek Wootton
    CV35 7QR Warwick
    Administrateur
    Leek Wootton House
    Warwick Road, Leek Wootton
    CV35 7QR Warwick
    EnglandBritish120520560001
    WINCH, Ronald Horace William
    20 Hildred House
    80 Ebury Mews
    SW1 London
    Administrateur
    20 Hildred House
    80 Ebury Mews
    SW1 London
    Australian35787260001

    IMBERCOURT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of set off
    Créé le 14 nov. 1984
    Livré le 28 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to teh chargee
    Brèves mentions
    All the property referred in the deed.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co LTD
    Transactions
    • 28 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    Letter of sef-off
    Créé le 19 oct. 1983
    Livré le 27 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Credit balances.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co LTD
    Transactions
    • 27 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 18 juil. 1983
    Livré le 22 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book & other debts uncalled capital, together with fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transactions
    • 22 juil. 1983Enregistrement d'une charge

    IMBERCOURT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 juin 2013Dissolved on
    23 sept. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0