HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED

HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01725441
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Clifton House
    Bunnian Place
    RG21 7JE Basingstoke
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EUROBAKE SERVICES LIMITED12 mai 199412 mai 1994
    FOOD TRENDS LIMITED27 juin 198327 juin 1983
    LIMESTATE LIMITED23 mai 198323 mai 1983

    Quels sont les derniers comptes de HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Teunis Christiaan Akkerman en tant qu'administrateur le 18 oct. 2011

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Marco Biagioni en tant que directeur le 18 oct. 2011

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 nov. 2011

    État du capital au 11 nov. 2011

    • Capital: GBP .25
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital au 09 juin 2010

    • Capital: GBP 0.25
    5 pagesSH19

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    14 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AKKERMAN, Teunis Christiaan
    Bunnian Place
    RG21 7JE Basingstoke
    Clifton House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Bunnian Place
    RG21 7JE Basingstoke
    Clifton House
    Hampshire
    United Kingdom
    LuxembourgDutchBusiness Consultant165715840001
    BRIVEZAC, Nadia
    92 Rue De Nancy
    Le Perreux Sur Marne
    94170
    France
    Secrétaire
    92 Rue De Nancy
    Le Perreux Sur Marne
    94170
    France
    FrenchAccount And Finance Manager120272400001
    HANDSCOMBE, Richard
    Budds Farm Cottage
    Burghclere
    RG20 9JY Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Budds Farm Cottage
    Burghclere
    RG20 9JY Newbury
    Berkshire
    British26411830001
    SLATER, Penelope Dawn
    4a Folly Cottages
    Burghclere
    RG20 9HF Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    4a Folly Cottages
    Burghclere
    RG20 9HF Newbury
    Berkshire
    BritishAccountant17035620001
    TRILL, Peter John
    Belvedere Woodlands Road
    Sonning Common
    RG4 9TE Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Belvedere Woodlands Road
    Sonning Common
    RG4 9TE Reading
    Berkshire
    British22518100001
    BELLAMY, Rodney John
    Denbigh House
    Jacksons Lane Hazelgrove
    SK7 6EL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Denbigh House
    Jacksons Lane Hazelgrove
    SK7 6EL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director10854680001
    BIAGIONI, Marco
    Lastra A Signa (Firenze)
    Via Delle Selve N. 27
    Italy
    Administrateur
    Lastra A Signa (Firenze)
    Via Delle Selve N. 27
    Italy
    ItalianCorporate Executive133740100001
    BRIVEZAC, Nadia
    92 Rue De Nancy
    Le Perreux Sur Marne
    94170
    France
    Administrateur
    92 Rue De Nancy
    Le Perreux Sur Marne
    94170
    France
    FrenchAccount And Finance Manager120272400001
    CARR, Michael Scott
    Highfield House
    Leckhamptonstead
    RG20 8QN Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Highfield House
    Leckhamptonstead
    RG20 8QN Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director48047490001
    CLEAU, Jacques
    La Meliniere
    Ecuille 49460
    FOREIGN France
    Administrateur
    La Meliniere
    Ecuille 49460
    FOREIGN France
    FrenchManaging Director52539110001
    COX, Edward George
    Charterhouse Development Capital Ltd
    7 Ludgate Broadway
    EC4V 6DX London
    Administrateur
    Charterhouse Development Capital Ltd
    7 Ludgate Broadway
    EC4V 6DX London
    British17027610001
    CUKIERMAN, Francis
    7 Square Latour Maubourg
    75007 Paris
    France
    Administrateur
    7 Square Latour Maubourg
    75007 Paris
    France
    FrenchCompany Executive76974620001
    DE BIOLLEY, Gauthier
    87 Rue De Sevres
    FOREIGN
    Paris 75006
    France
    Administrateur
    87 Rue De Sevres
    FOREIGN
    Paris 75006
    France
    BelgiumExecutive24447100001
    DEBRAY, Marc
    29 Avenue Georges Mandel
    FOREIGN Paris 75116
    France
    Administrateur
    29 Avenue Georges Mandel
    FOREIGN Paris 75116
    France
    FrenchBusiness Man61611480002
    FARAT, Jean Henri
    45 Rue De Lane Harpe
    FOREIGN Paris 75005
    France
    Administrateur
    45 Rue De Lane Harpe
    FOREIGN Paris 75005
    France
    FrenchBusinessman17027590001
    GORLIN, Ronald Vladimir
    125 Portland Road
    W11 4LW London
    Administrateur
    125 Portland Road
    W11 4LW London
    BritishCompany Director3470810001
    HANDSCOMBE, Richard
    Budds Farm Cottage
    Burghclere
    RG20 9JY Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Budds Farm Cottage
    Burghclere
    RG20 9JY Newbury
    Berkshire
    BritishAccountant26411830001
    MANN, John Delham
    290 Weed Street
    FOREIGN New Canaan
    Connecticut 06840
    Usa
    Administrateur
    290 Weed Street
    FOREIGN New Canaan
    Connecticut 06840
    Usa
    BritishCompany Director17027600001
    MILLET, Jean-Pierre
    9 Rue On Bemel
    FOREIGN 1150 Bruxelles
    Belgium
    Administrateur
    9 Rue On Bemel
    FOREIGN 1150 Bruxelles
    Belgium
    FrenchExecutive57462880004
    MOSS, Michael Geoffrey
    1 Longreach
    Bosham Hoe, Bosham
    PO18 8EU Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    1 Longreach
    Bosham Hoe, Bosham
    PO18 8EU Chichester
    West Sussex
    BritishCompany Director67182080001
    STRASSER, Alain
    29 Ruebenjamin
    Franklin
    75116 Paris
    France
    Administrateur
    29 Ruebenjamin
    Franklin
    75116 Paris
    France
    FrenchDirector63090250001
    TAILOUSE, Christian Pierre
    94 Bd De Le Tom Maubourg
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Administrateur
    94 Bd De Le Tom Maubourg
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FrenchDirector67522000001
    TRILL, Peter John
    Belvedere Woodlands Road
    Sonning Common
    RG4 9TE Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Belvedere Woodlands Road
    Sonning Common
    RG4 9TE Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant22518100001
    ULLENS, Guy
    Karel Van Lorreinenlaan
    FOREIGN Tervuren 3080
    Belgium
    Administrateur
    Karel Van Lorreinenlaan
    FOREIGN Tervuren 3080
    Belgium
    BelgianPresident24447080001

    HARRY'S MANAGEMENT SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 04 oct. 1993
    Livré le 15 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 oct. 1993
    Livré le 15 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the undertaking,property,and assets of the company as specified in the schedule,which also contains covenants by and restrictions on the company which protect and further define the charges.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over credit balances
    Créé le 03 sept. 1990
    Livré le 12 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to guarantee in favour of continental bank $200,000 dated 19/6/90
    Brèves mentions
    The sum of £115,000 together with interest accrued now or to be held by the chargee on an account numbered 67479448 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit agreement constituted by a letter from charterhouse japlit PLC
    Créé le 25 juil. 1984
    Livré le 09 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the dan cake handel a/s under the terms of a promisory note dated 25.7.84 to the chargee
    Brèves mentions
    £4,750,000 all monies from time to time standing to the credit of & deposit account erected pursuant to the terms of the deposit agreement referred to above.
    Personnes ayant droit
    • Chartershouse Japlit PLC
    Transactions
    • 09 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0