ABC12345678 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABC12345678 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01726611
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABC12345678 LIMITED ?

    • (5212) /

    Où se situe ABC12345678 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hillcairnie House
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Worcestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ABC12345678 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WINSTONMEAD LIMITED26 mai 201026 mai 2010
    WINSTONMEAD PLC25 mai 198325 mai 1983

    Quels sont les derniers comptes de ABC12345678 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ABC12345678 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    21 pages4.72

    Changement d'adresse du siège social de Aston House 5 Aston Road North Aston Birmingham West Midlands B6 4DS à Hillcairnie House St. Andrews Road Droitwich Worcestershire WR9 8DJ le 01 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    2 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2013

    18 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de * 4 Palace Avenue Paignton Devon TQ3 3HA United Kingdom* le 26 mars 2012

    2 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed winstonmead LIMITED\certificate issued on 24/02/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    24 févr. 2012

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM04 - MEANS IN ARTICLES

    CONNOT

    Changement d'adresse du siège social de * Ranger House Etruria Road Stoke on Trent Staffordshire ST1 5NH* le 26 janv. 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Adrian Hensby en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Morris en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Morris en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    legacy

    3 pagesMG04

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 déc. 2010

    17 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2011 au 31 déc. 2010

    1 pagesAA01

    Nomination de Stephen Mark Perry en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Holdcroft en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Deborah Haynes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 26 mai 2011

    8 pages1.3

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    7 pages1.4

    Qui sont les dirigeants de ABC12345678 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUNT, Cliff
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    Administrateur
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    EnglandBritishCommercial Director136015580001
    PERRY, Stephen Mark
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    Administrateur
    St. Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Hillcairnie House
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector87696020003
    BATER, Richard James
    470 Sutton Road
    SS2 5PN Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    470 Sutton Road
    SS2 5PN Southend On Sea
    Essex
    British55321500003
    HENSBY, Lucy Ann
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    Secrétaire
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    BritishDirector86508100003
    KNIGHT, Toni Suzanne
    90a Bellhouse Lane
    SS9 4PQ Leigh On Sea
    Essex
    Secrétaire
    90a Bellhouse Lane
    SS9 4PQ Leigh On Sea
    Essex
    British64520590004
    MORRIS, Robert
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Secrétaire
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    British150891220001
    ROBERTSON, Sheila Josephine
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Secrétaire
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    British4784580001
    BALL, Andrew
    The Edge
    Bay Hill St Margarets Bay
    CT15 6DU Dover
    Kent
    Administrateur
    The Edge
    Bay Hill St Margarets Bay
    CT15 6DU Dover
    Kent
    EnglandBritishDirector69112930003
    BATER, Richard James
    146 Hainault Avenue
    SS0 9EX Westcliff On Sea
    Essex
    Administrateur
    146 Hainault Avenue
    SS0 9EX Westcliff On Sea
    Essex
    BritishAccountant55321500002
    BUTCHER, Matthew
    7 Pargeters Hyam
    SS5 4EA Hockley
    Essex
    Administrateur
    7 Pargeters Hyam
    SS5 4EA Hockley
    Essex
    United KingdomBritishSales Director46227480003
    DESBOIS, Roderick
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Administrateur
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishSales Director164467240001
    DOULTON, Mark Daryl
    Castle Road
    SS6 7HT Rayleigh
    3
    Essex
    England
    Administrateur
    Castle Road
    SS6 7HT Rayleigh
    3
    Essex
    England
    BritishSales Director85426170003
    HAYNES, Deborah
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Administrateur
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector62319730003
    HENSBY, Adrian Trevor
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Administrateur
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector110016540002
    HENSBY, Benjamin Thomas, Director Of Operations
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Administrateur
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector Of Operations129048800002
    HENSBY, Lucy Ann
    Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    34
    Essex
    Administrateur
    Temple Way
    SS6 9PP Rayleigh
    34
    Essex
    United KingdomBritishDirector86508100004
    HENSBY, Lucy Ann
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    Administrateur
    1a Post Office Cottages
    Halstead Road
    CO6 3QH Eight Ash Green
    Essex
    BritishDirector86508100003
    HOLDCROFT, Philip
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Administrateur
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector62319640002
    KNIGHT, Toni Suzanne
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Administrateur
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector64520590004
    MORRIS, Robert
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    Administrateur
    Etruria Road
    ST1 5NH Stoke On Trent
    Ranger House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector63073600002
    PAXTON, Teri Louise
    169 Grove Road
    SS6 8UA Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    169 Grove Road
    SS6 8UA Rayleigh
    Essex
    BritishDirector75563490001
    ROBERTSON, Alexander Clifford
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritishDirector24291610001
    ROBERTSON, Sheila Josephine
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    276 Eastwood Road
    SS6 7LS Rayleigh
    Essex
    BritishDirector/Secretary4784580001
    TAYLOR, David Simon
    6 The South Stables
    Historic Dockyard
    ME4 4QX Chatham
    Essex
    Administrateur
    6 The South Stables
    Historic Dockyard
    ME4 4QX Chatham
    Essex
    BritishOperations Director112701020001
    WILSHER, Phillip
    50 Crown Hill
    SS6 7FR Rayleigh
    19 The Trinity
    Essex
    Administrateur
    50 Crown Hill
    SS6 7FR Rayleigh
    19 The Trinity
    Essex
    EnglandBritishSales Director140370800001

    ABC12345678 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 juil. 2010
    Livré le 28 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 oct. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 03 juin 2008
    Livré le 06 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transactions
    • 06 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 28 juil. 2005
    Livré le 29 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 29 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 2005
    Livré le 29 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 09 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of the ground floor of the building k/a premises on the east side of bentalls, pipps hill industrial area, basildon, essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 20 avr. 1991
    Livré le 04 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that part of the ground floor of the building k/a premises on the east side of bentalls pupps hill industrial area basildon essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Banks PLC
    Transactions
    • 04 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 21 juin 1988
    Livré le 24 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed charge on book & other debts present & future and the proceeds thereof as are not sold to & bought by alex lawrie receivables financing limited under the terms of an agreement of even date (see 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Alex Lawrie Receivable Financing Limited
    Transactions
    • 24 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 06 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 23 déc. 1986
    Livré le 30 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ABC12345678 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 févr. 2010Date of meeting to approve CVA
    26 mai 2011Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William Matthew Humphries Tait
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    David Harry Gilbert
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DateType
    21 févr. 2017Dissolved on
    19 mars 2012Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Elijah Thomas Bowen
    Aston House 5 Aston Road North
    Aston
    B6 4DS Birmingham
    practitioner
    Aston House 5 Aston Road North
    Aston
    B6 4DS Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0