IT 247 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIT 247 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01727950
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IT 247 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe IT 247 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    James House
    Warwick Road
    B11 2LE Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IT 247 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CORPORATE COMPUTERS LIMITED01 janv. 199601 janv. 1996
    AUTOCIM PLC13 nov. 198913 nov. 1989
    KNOWLEDGE TRANSFER LIMITED23 mai 198423 mai 1984

    Quels sont les derniers comptes de IT 247 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour IT 247 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour IT 247 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2014

    État du capital au 23 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 janv. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    20/01/2014
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share prem a/c cancelled 20/01/2014
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2009

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2008

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Statuts

    10 pagesMEM/ARTS

    Certificat de changement de nom

    Company name changed corporate computers LIMITED\certificate issued on 01/04/08
    2 pagesCERTNM

    Qui sont les dirigeants de IT 247 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RIGBY, Peter, Sir
    The Manor
    Clifford Chambers
    CV37 8HU Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    The Manor
    Clifford Chambers
    CV37 8HU Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish15654920006
    RIGBY, Steven Paul
    Banbury Road
    Ettington
    CV37 7NP Stratford Upon Avon
    The Limes
    Warwickshire
    Administrateur
    Banbury Road
    Ettington
    CV37 7NP Stratford Upon Avon
    The Limes
    Warwickshire
    EnglandBritish41996820011
    DANNELL, Geoffrey Brian
    28/30 Main Street
    Woodnewton
    PE8 5EB Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    28/30 Main Street
    Woodnewton
    PE8 5EB Peterborough
    Cambridgeshire
    British54402940002
    GILPIN, Nigel Peter
    172 Widney Lane
    B91 3LH Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    172 Widney Lane
    B91 3LH Solihull
    West Midlands
    British42299200003
    GOSSAGE, Neal Trevor
    20 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    Secrétaire
    20 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    British79300420001
    LEE, Andrew Julian
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    British17829780002
    MONKS, Terence John
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    British80344460001
    PONSFORD, Derek Desmond
    Elm Mead
    Mersea Road Langenhoe
    CO5 7LH Colchester
    Essex
    Secrétaire
    Elm Mead
    Mersea Road Langenhoe
    CO5 7LH Colchester
    Essex
    British41628530001
    RIGBY, James Peter
    The Bell House
    Old Warwick Road
    CV35 7BT Rowington
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Bell House
    Old Warwick Road
    CV35 7BT Rowington
    Warwickshire
    British88633720001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British12470210003
    TRUEMAN, John William
    7 Dampier Road
    CO6 1QZ Coggeshall
    Essex
    Secrétaire
    7 Dampier Road
    CO6 1QZ Coggeshall
    Essex
    British99004070001
    BIESBROEK, Gijsberet Cornelis
    Kasteelhof 8
    FOREIGN 2314xl Leiden
    The Netherlands
    Administrateur
    Kasteelhof 8
    FOREIGN 2314xl Leiden
    The Netherlands
    Dutch26883250001
    DAVIS, Neville
    Manyons Church Lane
    Barkway
    SG8 8EJ Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Manyons Church Lane
    Barkway
    SG8 8EJ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish17829820001
    HALESTRAP, Jonathan
    12 Culworth Close
    CV21 1TX Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    12 Culworth Close
    CV21 1TX Rugby
    Warwickshire
    British30431690001
    KOFFRIE, Frans Herman Jan
    Van Ostadelaan 6
    3712 AV Huis Ter Heide
    Holland
    Administrateur
    Van Ostadelaan 6
    3712 AV Huis Ter Heide
    Holland
    Dutch56679360001
    LEE, Andrew Julian
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Crossways Farm
    London Road Barley
    SG8 8AQ Royston
    Hertfordshire
    British17829780002
    MORGAN, Paul
    Bostock House
    Broadlands
    NN6 9AZ Pitsford
    Northampton
    Administrateur
    Bostock House
    Broadlands
    NN6 9AZ Pitsford
    Northampton
    British85893350001
    REDMAN, Gerald Frederick
    Herm 26 Little Baddow Road
    CM3 4NT Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Herm 26 Little Baddow Road
    CM3 4NT Chelmsford
    Essex
    British89386360001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    Rivendell
    Little Aston Park Road Little Aston
    B74 3BZ Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish12470210003
    STOCKLEY, Clifford Orchard
    21 Field Road
    WS13 7RU Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    21 Field Road
    WS13 7RU Lichfield
    Staffordshire
    British30431680002
    THOMAS, Carl
    Zonneweilaan 1
    5263 Ea Vught
    The Netherlands
    Administrateur
    Zonneweilaan 1
    5263 Ea Vught
    The Netherlands
    Dutch62392320001
    TRUEMAN, John William
    7 Dampier Road
    CO6 1QZ Coggeshall
    Essex
    Administrateur
    7 Dampier Road
    CO6 1QZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritish99004070001

    IT 247 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Single debenture
    Créé le 02 juin 1987
    Livré le 05 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Inc all heritable property & assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 01 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0