JHP GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJHP GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01729661
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JHP GROUP LIMITED ?

    • Autres enseignements n.c.a. (85590) / Enseignement

    Où se situe JHP GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    32 Eyre Street
    First Floor
    S1 4QZ Sheffield
    South Yorkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JHP GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JHP TRAINING LIMITED01 août 198301 août 1983
    HUGH PITMAN TRAINING LIMITED05 juil. 198305 juil. 1983
    MIGHTYWORLD LIMITED07 juin 198307 juin 1983

    Quels sont les derniers comptes de JHP GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 avr. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour JHP GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Notification de Dimensions Training Topco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 janv. 2022

    2 pagesPSC02
    XAZ9MAP4

    Cessation de Wayne Janse Van Rensburg en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 janv. 2022

    1 pagesPSC07
    XAZ9MA6A

    Changement d'adresse du siège social de 9a Wainsford Road Pennington Lymington Hampshire SO41 8GD à 32 Eyre Street First Floor Sheffield South Yorkshire S1 4QZ le 07 mars 2022

    1 pagesAD01
    XAZ9L2UZ

    Changement d'adresse du siège social de 32 Eyre Street First Floor Sheffield South Yorkshire S1 4QZ England à 9a Wainsford Road Pennington Lymington Hampshire SO41 8GD le 24 févr. 2022

    2 pagesAD01
    AAYCI2LD

    Nomination de Mr Andrew Niedzwiecki en tant qu'administrateur le 27 janv. 2022

    2 pagesAP01
    AAYCI2LL

    Cessation de la nomination de Wayne Janse Van Rensburg en tant que directeur le 27 janv. 2022

    1 pagesTM01
    AAY7FDPT

    Nomination de Mrs Pamela Mary Rae-Welsh en tant qu'administrateur le 27 janv. 2022

    2 pagesAP01
    AAY7FDPL

    Comptes pour une petite entreprise établis au 27 avr. 2021

    7 pagesAA
    XAWKZIYP

    Déclaration de confirmation établie le 23 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XADNW1AB

    Déclaration de confirmation établie le 17 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XAD7Z8UR

    Changement d'adresse du siège social de Dearing House 1 Young Street Sheffield S1 4UP à 32 Eyre Street First Floor Sheffield South Yorkshire S1 4QZ le 10 août 2021

    1 pagesAD01
    XAAK4U2A

    Comptes pour une petite entreprise établis au 27 avr. 2020

    6 pagesAA
    AA0I93HF

    Déclaration de confirmation établie le 17 sept. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X9FNNF9T

    Comptes pour une petite entreprise établis au 27 avr. 2019

    6 pagesAA
    S93N2XJE

    Période comptable précédente raccourcie du 28 avr. 2019 au 27 avr. 2019

    1 pagesAA01
    X8XBQ0B5

    Déclaration de confirmation établie le 17 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8EF45Q1

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 avr. 2018

    6 pagesAA
    A89XESBE

    Période comptable précédente raccourcie du 29 avr. 2018 au 28 avr. 2018

    1 pagesAA01
    X83ZKXFT

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2018 au 29 avr. 2018

    1 pagesAA01
    X7XSQGY3

    Déclaration de confirmation établie le 17 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7H54KYW

    Notification de Wayne Janse Van Rensburg en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juin 2018

    2 pagesPSC01
    X7H542II

    Cessation de Learndirect Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 juin 2018

    1 pagesPSC07
    X7H53OVD

    Qui sont les dirigeants de JHP GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NIEDZWIECKI, Andrew
    Wainsford Road
    Pennington
    SO41 8GD Lymington
    9a
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wainsford Road
    Pennington
    SO41 8GD Lymington
    9a
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector205992720001
    RAE-WELSH, Pamela Mary
    Wainsford Road
    Pennington
    SO41 8GD Lymington
    9a
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wainsford Road
    Pennington
    SO41 8GD Lymington
    9a
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector215888510001
    ANDERSON, Margaret
    5 College Green
    Wanborough
    SN4 0AZ Swindon
    Wiltshire
    Secrétaire
    5 College Green
    Wanborough
    SN4 0AZ Swindon
    Wiltshire
    British11878420001
    HARRIS, Ralph William
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Secrétaire
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    British148241090001
    KORAL, Greg
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Secrétaire
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    163187500001
    PITMAN, Helen Ruth
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    British73397610001
    WARD, Lesley Ruth
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    United Kingdom
    British175718850001
    CHAMBERS, James Robert
    The Old Vicarage
    Hackney Lane Barlow
    S18 7TR Dronfield
    Derbyshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Hackney Lane Barlow
    S18 7TR Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritishChief Executive Officer121875910001
    CHARTERIS, William John
    2 Summers Close
    The Hollies
    LE9 7QP Kirkby Mallory
    Leicestershire
    Administrateur
    2 Summers Close
    The Hollies
    LE9 7QP Kirkby Mallory
    Leicestershire
    BritishManaging Director55185140001
    DEAVILLE, John Paul
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Administrateur
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director99794540001
    GREENHALGH, Tracie Rose
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director148240990001
    HARRIS, Ralph William
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Administrateur
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director174533780002
    HENDERSON-MORROW, Kristian
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Administrateur
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director148241030001
    HILLS, Kenneth Cumming
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    Administrateur
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    United KingdomBritishCompany Director159009950001
    JANSE VAN RENSBURG, Wayne
    Eyre Street
    First Floor
    S1 4QZ Sheffield
    32
    South Yorkshire
    England
    Administrateur
    Eyre Street
    First Floor
    S1 4QZ Sheffield
    32
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector152557640001
    JONES, Sarah Elizabeth
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector103575870002
    KORAL, Gregory David
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Administrateur
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishDirector108145070001
    LEWIS, Derek Compton
    Woodlands Farmhouse Thoby Lane
    Mount Nessing
    CM15 0SY Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Woodlands Farmhouse Thoby Lane
    Mount Nessing
    CM15 0SY Brentwood
    Essex
    EnglandBritishCompany Director And Advisor56972220001
    PEACE, Roger Kenneth
    Mill Field
    CV37 8UX Pebworth
    Stamford House
    Stratford-Upon-Avon
    Administrateur
    Mill Field
    CV37 8UX Pebworth
    Stamford House
    Stratford-Upon-Avon
    EnglandBritishChartered Accountant41697510007
    PETERS, David Charles
    93 Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    Middlesex
    Administrateur
    93 Percy Road
    TW12 2JS Hampton
    Middlesex
    BritishCompany Director44700870001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director55231490005
    PITMAN, Henry John
    Home Farm
    Bourton On The Hill
    GL56 9AF Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Administrateur
    Home Farm
    Bourton On The Hill
    GL56 9AF Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishProperty Sales Negotiator55231490003
    PITMAN, John Hugh
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    BritishChairman1262260001
    PITMAN, John Hugh
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Foxley House
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    BritishChairman & Chief Executive1262260001
    PITMAN, Rosemary Alice
    Bakers House
    Brokenborough
    SN16 0HY Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Bakers House
    Brokenborough
    SN16 0HY Malmesbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director20210900001
    PITMAN, Thomas Edward
    Hofland Road
    W14 0LN London
    17
    Administrateur
    Hofland Road
    W14 0LN London
    17
    United KingdomBritishCompany Director83610320002
    PITMAN, Thomas Edward
    Foxley House
    Foxley
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Foxley House
    Foxley
    SN16 0JJ Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director83610320001
    PITMAN, William Hugh
    18 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    Administrateur
    18 Macaulay Road
    SW4 0QX London
    BritishFund Manager104764070001
    RICHARDSON, Helen Kathryn
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    Administrateur
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director147736990001
    ROBERTS, Stuart Kurt
    10 Jerrard Drive
    B75 7TN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    10 Jerrard Drive
    B75 7TN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant22138140001
    SHERLOCK, Brian Foster
    Landsdowne Crescent
    Willes Road
    CV32 4PR Leamington Spa
    25
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Landsdowne Crescent
    Willes Road
    CV32 4PR Leamington Spa
    25
    Warwickshire
    United Kingdom
    BritishCompany Director134663880002
    SWARBRICK, John Frederick
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    Administrateur
    Siskin Drive
    Middlemarch Business Park
    CV3 4FJ Coventry
    3 Riverstone Court
    EnglandBritishCompany Director84418420005
    WILLIAMS, Stephen Fred
    81 Links Drive
    B91 2DJ Solihull
    West Midlands
    England
    Administrateur
    81 Links Drive
    B91 2DJ Solihull
    West Midlands
    England
    BritishManaging Director34195840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JHP GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dimensions Training Topco Limited
    Wainsford Road
    Pennington
    SO41 8GD Lymington
    9a
    Hampshire
    England
    27 janv. 2022
    Wainsford Road
    Pennington
    SO41 8GD Lymington
    9a
    Hampshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement13792236
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Mr Wayne Janse Van Rensburg
    Eyre Street
    First Floor
    S1 4QZ Sheffield
    32
    South Yorkshire
    England
    23 juin 2018
    Eyre Street
    First Floor
    S1 4QZ Sheffield
    32
    South Yorkshire
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Learndirect Limited
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    England
    22 juin 2018
    1 Young Street
    S1 4UP Sheffield
    Dearing House
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies For England And Wales
    Numéro d'enregistrement03980770
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Young Street
    S1 4UP Sheffield
    1
    England
    06 avr. 2016
    Young Street
    S1 4UP Sheffield
    1
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement8153096
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    JHP GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 déc. 2013
    Livré le 06 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 06 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 juil. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 30 nov. 2012
    Livré le 04 déc. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Holdings Limited (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 04 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 08 janv. 2010
    Livré le 20 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the seurity trustee and the beneficiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transactions
    • 20 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 08 janv. 2010
    Livré le 15 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee, the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Hugh Pitman as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 15 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 janv. 2010
    Livré le 15 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 15 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 23 mars 2006
    Livré le 29 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The rent deposit (initially £2,330.00). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • L & C Investments Limited
    Transactions
    • 29 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 mars 2004
    Livré le 24 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 06 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £2,330.
    Personnes ayant droit
    • LCP Securities Limited
    Transactions
    • 06 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 juil. 1999
    Livré le 09 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 09 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 juin 1999
    Livré le 16 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal amounts detailed or owing under an instrument constituting floating rate secured "a" loan notes 2000 of £1 each both of even date issued by the company (as amended supplemental varied or substantial from time to time and other sums due or to become due from the company to the chargee arising out of or in connection with the act or matters referred to in clause 7 of the debenture on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Hugh Pitman ("Lender 1") and John Hugh Pitman, Helen Ruth Pitman and Alexander Williammartin Mitchell as Trustees of the Settlement Dated 4TH June 1985 ("Lender 2") and John Hugh Pitman, Helen Ruth Pitman and Alexander William Martin Mitchell as Trustees of the Settlement
    • Dated 23RD June 1997 ("Lender 3")
    Transactions
    • 16 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 mai 1999
    Livré le 14 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an instrument constituting floating rate secured loan notes 2000 of £1 each both dated 26TH may 1999 and issued by the company (as amended,supplemental, varied or substantial from time to time)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Helen Ruth Pitman
    • John Hugh Pitman
    • Henry John Pitman
    • Alexander William Martin Mitchell(As Trustees of the Settlement Dated 4TH June 1985)
    Transactions
    • 14 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 juil. 1998
    Livré le 17 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 mai 1998
    Livré le 29 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 oct. 1993
    Livré le 11 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 sept. 1983
    Livré le 10 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1983Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0