A.G. LEASING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéA.G. LEASING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01730912
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de A.G. LEASING LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe A.G. LEASING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de A.G. LEASING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DESKGALLEY LIMITED10 juin 198310 juin 1983

    Quels sont les derniers comptes de A.G. LEASING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour A.G. LEASING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 juil. 2012

    4 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 févr. 2012

    4 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 244 Upton Road Bristol BS99 7UJ le 10 mars 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 17 févr. 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2010

    État du capital au 15 avr. 2010

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    2 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Rachel Louise Gibbs Fennell le 01 déc. 2009

    3 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas James Keveth le 01 déc. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Trevor Martin Williams le 01 déc. 2009

    3 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Matthew Robert Phillips le 01 déc. 2009

    3 pagesCH01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    2 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 30 sept. 2007

    2 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 30 sept. 2006

    2 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de A.G. LEASING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FENNELL, Rachel Louise Gibbs
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Secrétaire
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    British116031910002
    KEVETH, Nicholas James
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritishAccountant116015800002
    PHILLIPS, Matthew Robert
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritishLawyer99604560003
    WILLIAMS, Trevor Martin
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritishChartered Secretary61973760001
    COWIN, Robert Andrew
    2 Rhydhelig Avenue
    CF14 4DD Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire
    2 Rhydhelig Avenue
    CF14 4DD Cardiff
    South Glamorgan
    BritishAccountant61107980002
    DEFT, Christopher
    8 Clyde Avenue
    Keynsham
    BS31 1PZ Bristol
    Secrétaire
    8 Clyde Avenue
    Keynsham
    BS31 1PZ Bristol
    British5770090002
    HAYES, Christopher Neal
    55 Delafield Road
    NP7 7AW Abergavenny
    Gwent
    Secrétaire
    55 Delafield Road
    NP7 7AW Abergavenny
    Gwent
    British43575110001
    HUGHES, Kevin Gordon
    Tynypandy The Rectory
    Llanmartin
    NP6 2EB Newport
    Gwent
    Secrétaire
    Tynypandy The Rectory
    Llanmartin
    NP6 2EB Newport
    Gwent
    BritishAccountant43693600002
    JONES, Wayne
    4 Brummell Drive
    Creigiau
    CF15 9NX Cardiff
    City & County Of Cardiff
    Secrétaire
    4 Brummell Drive
    Creigiau
    CF15 9NX Cardiff
    City & County Of Cardiff
    BritishAccountant79132950001
    BOLT, Graham Martin
    2 Philpotts Court
    NP16 7LL Tidenham
    South Gloucestershire
    Administrateur
    2 Philpotts Court
    NP16 7LL Tidenham
    South Gloucestershire
    BritishSalesman53974060003
    COOPER, Alison Jane
    6 Stoke Paddock Road
    Stoke Bishop
    BS9 2DJ Bristol
    Administrateur
    6 Stoke Paddock Road
    Stoke Bishop
    BS9 2DJ Bristol
    EnglandBritishChartered Accountant73712680003
    COWIN, Robert Andrew
    2 Rhydhelig Avenue
    CF14 4DD Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    2 Rhydhelig Avenue
    CF14 4DD Cardiff
    South Glamorgan
    BritishAccountant61107980002
    FORTON, Robert
    Laie De La Traque 6
    B 1300 Limal
    Belgium
    Administrateur
    Laie De La Traque 6
    B 1300 Limal
    Belgium
    BelgianBusiness Development43574560001
    GREEN, Peter Clifford
    4 Fair View
    High Beech
    NP6 5BX Chepstow
    Gwent
    Administrateur
    4 Fair View
    High Beech
    NP6 5BX Chepstow
    Gwent
    BritishProduction39279140001
    HANNAFORD, Richard Charles
    14 Yew Tree Close
    Lower Langford
    BS40 5DP Bristol
    Administrateur
    14 Yew Tree Close
    Lower Langford
    BS40 5DP Bristol
    EnglandBritishChartered Accountant7333680002
    HAYES, Christopher Neal
    55 Delafield Road
    NP7 7AW Abergavenny
    Gwent
    Administrateur
    55 Delafield Road
    NP7 7AW Abergavenny
    Gwent
    BritishDirector43575110001
    HUGHES, Kevin Gordon
    Tynypandy The Rectory
    Llanmartin
    NP6 2EB Newport
    Gwent
    Administrateur
    Tynypandy The Rectory
    Llanmartin
    NP6 2EB Newport
    Gwent
    BritishAccountant43693600002
    JONES, Wayne
    4 Brummell Drive
    Creigiau
    CF15 9NX Cardiff
    City & County Of Cardiff
    Administrateur
    4 Brummell Drive
    Creigiau
    CF15 9NX Cardiff
    City & County Of Cardiff
    BritishAccountant79132950001
    MINSHULL, Brian Sylvester
    Colwinston House
    CF7 7NJ Colwinston
    South Glamorgan
    Administrateur
    Colwinston House
    CF7 7NJ Colwinston
    South Glamorgan
    BritishManaging Director14309690002
    PAINBLANC, Fernand
    Villa Lamandier
    Chemin De Senaugin 6
    FOREIGN 1162 St Prex
    Switzerland
    Administrateur
    Villa Lamandier
    Chemin De Senaugin 6
    FOREIGN 1162 St Prex
    Switzerland
    BelgianChairman14970550001
    PAINBLANC, Roger Fernand
    1 Kastanjelaan
    2020 Antwerp
    FOREIGN
    Belgium
    Administrateur
    1 Kastanjelaan
    2020 Antwerp
    FOREIGN
    Belgium
    BelgianDirector14467450001

    A.G. LEASING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 mai 1994
    Livré le 06 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of any of the finance documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerlandas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined Therein)
    Transactions
    • 06 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First fixed charge
    Créé le 05 janv. 1990
    Livré le 12 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right, title and interest of the company. (For full details see doc M97).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 24 mai 1985
    Livré le 14 juin 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for two loan facilities (in amounts of £226,300 & £520,490) 24/5/85 & under or pursuant to all other arrangements made between the company & the chargee
    Brèves mentions
    First fixed charge of all the companys right, title & interest present & future (see doc M17) in the equipment, the lease, the insurances, the rents & all moneys payable to the company under the lease security.
    Personnes ayant droit
    • First National Bank of Boston
    Transactions
    • 14 juin 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 17 oct. 1984
    Livré le 24 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £56,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 17/10/84 and this charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over headlease of equipment no 85CH013 dated 27/6/84 (see doc M16).
    Personnes ayant droit
    • First National Bank of Boston
    Transactions
    • 24 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 30 août 1983
    Livré le 08 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement 30/8/83
    Brèves mentions
    The equipment subject of a lese 30/6/83 any guarantee indemnity or other security given in connection with any of the leases rents & other monies.
    Personnes ayant droit
    • First National Bank of Boston
    Transactions
    • 08 sept. 1983Enregistrement d'une charge

    A.G. LEASING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 oct. 2012Dissolved on
    17 févr. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Peter George Roach
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Fourth Floor
    BS1 6AA One Victoria Street
    Bristol
    practitioner
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Fourth Floor
    BS1 6AA One Victoria Street
    Bristol
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0