QBE UK FINANCE I LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQBE UK FINANCE I LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01733599
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QBE UK FINANCE I LIMITED ?

    • (7415) /
    • (7487) /

    Où se situe QBE UK FINANCE I LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Plantation Place
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QBE UK FINANCE I LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SANDSALE LIMITED16 sept. 199616 sept. 1996
    QBE INSURANCE (UK) LIMITED05 sept. 198305 sept. 1983
    SANDSALE LIMITED22 juin 198322 juin 1983

    Quels sont les derniers comptes de QBE UK FINANCE I LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour QBE UK FINANCE I LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 08 sept. 2011

    • Capital: GBP 100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    11 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Paul Burns le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David James Winkett le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sharon Maria Boland le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de QBE UK FINANCE I LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOLAND, Sharon Maria
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Secrétaire
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    British60727940002
    BURNS, Steven Paul
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Administrateur
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    United KingdomBritish18761850004
    WINKETT, David James
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    Administrateur
    30 Fenchurch Street
    EC3M 3BD London
    Plantation Place
    British73175560002
    BOWER, Martin Andrew
    33 Burns Avenue
    SS13 3AG Basildon
    Essex
    Secrétaire
    33 Burns Avenue
    SS13 3AG Basildon
    Essex
    British23307030001
    GREENHALGH, Mary Denise
    61 Alexandra Road
    TW9 2BT Kew
    Surrey
    Secrétaire
    61 Alexandra Road
    TW9 2BT Kew
    Surrey
    British42172510001
    MACGREGOR, Richard James
    14 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DR London
    Secrétaire
    14 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DR London
    British83245460001
    PALLOT, Hugh Glen
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    Secrétaire
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    British14485660002
    WILLIAMS, Adrian Charles Harold
    The Upper Flat
    94 Offord Road
    N1 1PF London
    Secrétaire
    The Upper Flat
    94 Offord Road
    N1 1PF London
    British103327620002
    BAILEY, Joanne
    27 Molasses House
    Clove Hitch Quay, Battersea
    SW11 3TN London
    Administrateur
    27 Molasses House
    Clove Hitch Quay, Battersea
    SW11 3TN London
    New Zealand125214680001
    BOWER, Martin Andrew
    33 Burns Avenue
    SS13 3AG Basildon
    Essex
    Administrateur
    33 Burns Avenue
    SS13 3AG Basildon
    Essex
    British23307030001
    BROWN, Gordon Leslie
    Elmstead Garth
    Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    Administrateur
    Elmstead Garth
    Wood Drive
    BR7 5EU Chislehurst
    Kent
    British16430200001
    CLONEY, Edwin John
    142 Kurraba Road
    Neutral Bay New South Wales 2089
    Australia
    Administrateur
    142 Kurraba Road
    Neutral Bay New South Wales 2089
    Australia
    Australian45470590001
    FOGARTY, Desmond
    1 St Andrews
    Curragha
    Ashbourne
    Co Meath
    Ireland
    Administrateur
    1 St Andrews
    Curragha
    Ashbourne
    Co Meath
    Ireland
    Irish79250160001
    GLEN, Paul Edward
    Marlands Court
    Itchingfield
    RH13 0NN Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Marlands Court
    Itchingfield
    RH13 0NN Horsham
    West Sussex
    British43947920002
    GOLDING, Adam Jon
    17 Woodland Way
    AL6 0RZ Welwyn
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Woodland Way
    AL6 0RZ Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish126538020001
    GRANT, Robert Michael
    Betsoms Hill
    The Avenue
    TN16 2EE Westerham
    Kent
    Administrateur
    Betsoms Hill
    The Avenue
    TN16 2EE Westerham
    Kent
    British70624210001
    HOSKING, Paul John
    The Main House
    2a Pickford Road
    AL3 8RU Markyate
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Main House
    2a Pickford Road
    AL3 8RU Markyate
    Hertfordshire
    United KingdomBritish55333350002
    LEWIS, Wayne
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    EnglandBritish45534010003
    MACGREGOR, Richard James
    14 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DR London
    Administrateur
    14 Cheyne Avenue
    South Woodford
    E18 2DR London
    EnglandBritish83245460001
    O'REGAN, Michael Ferghal
    1 Northshore
    IRISH Upper Rathdown Greystones
    County Wicklow
    Ireland
    Administrateur
    1 Northshore
    IRISH Upper Rathdown Greystones
    County Wicklow
    Ireland
    Irish66745340003
    SNOXHILL, Douglas James
    High Banks Scotts Hill
    South Park
    TN13 1EL Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    High Banks Scotts Hill
    South Park
    TN13 1EL Sevenoaks
    Kent
    British16430190001
    TOLLIFSON, Edna Gayle
    46 Watkin Street
    Newtown
    Nsw 2042
    Australia
    Administrateur
    46 Watkin Street
    Newtown
    Nsw 2042
    Australia
    Australian76610690001

    QBE UK FINANCE I LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Reinsurance deposit agreement
    Créé le 23 févr. 1988
    Livré le 15 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any and all of the present or future actual or contingent obligations of the chargor to the bank under the re-insurance deposit agreement or under any agreement (see form 395 for further details).
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 15 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 11 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Sucurity agreement
    Créé le 12 janv. 1988
    Livré le 18 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the chargor's rights title and interest in and to all securities which are held by, to the order for the account or under the control or direction of the bank. (See form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 18 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 11 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0