C J & J J ENTERPRISES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | C J & J J ENTERPRISES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01735471 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe C J & J J ENTERPRISES LIMITED ?
Adresse du siège social | Gawsworth House Westmere Drive CW1 6XB Crewe Cheshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de C J & J J ENTERPRISES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 21 févr. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour C J & J J ENTERPRISES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr William Grimsey le 13 mai 2011 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Robbins en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Dawn Michelle Wilkinson le 11 oct. 2010 | 3 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Thomas Christopher Morgan le 11 oct. 2010 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Bird en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Patrick Gladwin le 11 oct. 2010 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Brian Keith Robbins le 11 oct. 2010 | 3 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 21 févr. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Brian Keith Robbins en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Thomas Christopher Morgan en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Unitt en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Penelope Teale en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes établis au 22 févr. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Comptes établis au 24 févr. 2008 | 8 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de C J & J J ENTERPRISES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILKINSON, Dawn Michelle | Secrétaire | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire United Kingdom | British | 105435010001 | ||||||
GLADWIN, Robert Patrick | Administrateur | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | Director | 130288970001 | ||||
GRIMSEY, William | Administrateur | 9 The Avenue WD7 7DG Radlett Tall Timbers Hertfordshire | United Kingdom | British | Retailer | 50647840004 | ||||
MORGAN, Thomas Christopher | Administrateur | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | None | 152428250002 | ||||
BOOTH, Christopher Paul | Secrétaire | 65 Hall Ing Lane Honley HD9 6QW Huddersfield West Yorkshire | British | Company Secretary | 14661120001 | |||||
HOSKINS, William | Secrétaire | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 123592580001 | |||||
KEANE, Mark Patrick | Secrétaire | The Grange Barn Moor Lane Kirkby Overblow HG3 1HU Harrogate | British | Solicitor | 96510470001 | |||||
MADELEY, Michael Leslie | Secrétaire | Newby Manor Huby LS17 0EY Leeds Yorkshire | British | 6114710001 | ||||||
RIMMER, Barbara | Secrétaire | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||
UNITT, Andrew Vaughan | Secrétaire | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | British | Accountant | 182500750001 | |||||
WILLIAMS, David Robert | Secrétaire | 15 St Stephens Road CH42 8PP Prenton Merseyside | British | 157062220001 | ||||||
WILSON, Geoffrey Charles | Secrétaire | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | 72996700001 | ||||||
ARCHER, William Ernest | Administrateur | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | Director | 15170380004 | |||||
BIRD, Richard Sidney | Administrateur | 80 Wolsey Road HA6 2EH Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Director | 111500210002 | ||||
COHEN, John Alexander | Administrateur | 7 Rectory Gardens Wollaton NG8 2AR Nottingham Nottinghamshire | England | British | Company Director | 25406220001 | ||||
FOSTER, David Charles Geoffrey | Administrateur | 3 Cottage Farm Close Osgathorpe LE12 9UE Loughborough Leicestershire | British | Solicitor | 52040210002 | |||||
HOSKINS, William | Administrateur | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 123592580001 | |||||
JOHNSON, Stephen Richard | Administrateur | The Old Vicarage Lower Dunsforth YO26 9SA York | England | British | Director | 87398750001 | ||||
MADELEY, John Edward | Administrateur | Brookside Moor Lane Burley In Wharfedale LS29 7AF Ilkley West Yorkshire | British | Director | 12035130001 | |||||
MADELEY, Michael Leslie | Administrateur | Newby Manor Huby LS17 0EY Leeds Yorkshire | British | Director | 6114710001 | |||||
ROBBINS, Brian Keith | Administrateur | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | American | None | 153559370002 | ||||
SCRIBBINS, Rodney Martin | Administrateur | The Hemploe Hemploe Road NN6 6HF Welford Northampton | England | British | Company Director | 98160250001 | ||||
TEALE, Penelope Jane | Administrateur | 1 Weldon Rise Off Pitcher Lane MK5 8BW Loughton Milton Keynes | United Kingdom | British | Director | 126053080001 | ||||
THOMAS, Shelley Frances | Administrateur | Everest Road SK14 4DX Hyde Woodside Farm Cheshire | United Kingdom | British | Director | 133244600001 | ||||
UNITT, Andrew Vaughan | Administrateur | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | England | British | Chief Financial Officer | 182500750001 | ||||
UNITT, Andrew Vaughan | Administrateur | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | England | British | Accountant | 182500750001 | ||||
WEST, Gary James | Administrateur | Merlewood House Russell Road TW17 8JS Shepperton Middlesex | United Kingdom | British | Director | 127476430001 | ||||
WILLIAMS, David Robert | Administrateur | 15 St Stephens Road CH42 8PP Prenton Merseyside | United Kingdom | British | Finance Director Focus Div | 157062220001 | ||||
WILSON, Geoffrey Charles | Administrateur | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | Director | 72996700001 |
C J & J J ENTERPRISES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Créé le 19 août 1998 Livré le 03 sept. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due by any group company (as therein defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries, as therein defined) under the banking documents and the mezzanine loan agreement (both as therein defined) whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise and in each case under the working capital facility letter | |
Brèves mentions F/H property known as bonehill road tamworth t/n SF319160, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 26 janv. 1987 Livré le 05 févr. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 1.74 acres of land of the neath abbey business park, neath, west glamorgan together with the unit erected or in the course of erection on same part or parts thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge on building agreement | Créé le 09 juil. 1986 Livré le 21 juil. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All the inerest of the company in a building agreement dated 22 5 86 between the company and neath borough council relating to all that piece of land situate of the neath abbey business park, neath west glamorgan and all the licences comprised therein and all buildings erected thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0