IN-TO-SAVE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIN-TO-SAVE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01739084
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IN-TO-SAVE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe IN-TO-SAVE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Novomatic House South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Wales
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de IN-TO-SAVE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour IN-TO-SAVE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Zane Cedomir Mersich le 11 janv. 2022

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Astra House Kingsway Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3RY Wales à Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB

    1 pagesAD02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Zane Cedomir Mersich le 22 sept. 2020

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB Wales à Novomatic House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB le 13 juil. 2020

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Birch House Woodlands Business Park Milton Keynes Buckinghamshire MK14 6EW England à Morris House South Road Bridgend Industrial Estate Bridgend CF31 3EB le 16 mars 2020

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Neil Paramore en tant que directeur le 28 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Paramore en tant que secrétaire le 28 janv. 2020

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Andrew Mark Glennon en tant que secrétaire le 28 janv. 2020

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Andrew Mark Glennon en tant qu'administrateur le 28 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 11 juin 2016

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de IN-TO-SAVE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Secrétaire
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    266960810001
    GLENNON, Andrew Mark
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Administrateur
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    WalesBritish260666740001
    MERSICH, Zane Cedomir
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    Administrateur
    South Road
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3EB Bridgend
    Novomatic House
    Wales
    EnglandSouth African131382980002
    HARVEY, Peter James
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3 Gates Court
    High Street
    SG7 6GA Baldock
    Hertfordshire
    British103770410001
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Secrétaire
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    British7148530001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Secrétaire
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    209558860001
    WILSON, Karen
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British151965340002
    YANTIN, Gary Laurence
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    Secrétaire
    85 Cardinal Avenue
    WD6 1ST Borehamwood
    Hertfordshire
    British119004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    Secrétaire
    Black Friars Lane
    EC4V 6HD London
    20
    39182980001
    BOGG, Dyson Peter Kelly
    Fosbury Mews
    Bayswater
    W2 3JE London
    8
    Administrateur
    Fosbury Mews
    Bayswater
    W2 3JE London
    8
    Australian113701350003
    BRYDON, Leslie
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    Administrateur
    1 Victoria House
    Market Place
    DL8 4NP Middleham
    North Yorkshire
    British103621720001
    EVANS, Byron
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    Administrateur
    Keepers Cottage
    46 High Street Whittlebury
    NN12 8JX Northampton
    British105734100001
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDING, Nicholas Simon
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Old Wharf House
    The Wharf
    MK14 5AS Great Linford
    Buckinghamshire
    EnglandBritish150860820001
    HARVEY, Peter James
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Woodlands Business Park
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish103770410003
    HUGHES, Harry Stuart
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    Administrateur
    Clervaux Dalton Road
    Croft
    DL2 2NR Darlington
    Co Durham
    United KingdomBritish7148530001
    HUGHES, John Ashley
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    Administrateur
    Longwood
    Darlington Road
    DL10 7EB Richmond
    North Yorkshire
    United KingdomBritish112694600001
    PARAMORE, Neil
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    1 Kingsway
    Bridgend Industrial Estate
    CF31 3RY Bridgend
    Astra House
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish79707840002
    REDMOND, Brendan Patrick
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    Administrateur
    57 Crisp Street
    3188 Hampton
    Victoria 3188
    Australia
    AustraliaIrish117576220001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IN-TO-SAVE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    06 avr. 2016
    Breckland
    Linford Wood
    MK14 6EW Milton Keynes
    Birch House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05382157
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    IN-TO-SAVE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 04 avr. 2007
    Livré le 17 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 17 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 14 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the benefit of the finance parties (the "the security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 2005
    Livré le 09 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mai 1998
    Livré le 30 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Créé le 09 sept. 1996
    Livré le 17 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the standard security
    Brèves mentions
    The plot or area of ground lying in the burgh of kirkcaldy and county of fife extending to 865 square metres bounded on or twoards the southwest by whytescauseway, kirkcaldy along which it extends 15.3 metres.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 août 1994
    Livré le 10 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from leisure promotions limited to the chargee on any accouny whatsoever and by the company under the provisions of the charge
    Brèves mentions
    Land and buildings on south side of boathouse lane stockton on tees. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 août 1994
    Livré le 10 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a bridge end saw mills boathouse lane stockton on tees. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 21 juil. 1994
    Livré le 22 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 02 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 ref M366C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 janv. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 06 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 12 mars 1991
    Livré le 27 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit G3, boathouse lane stockton-on-tees cleveland title no ce 76294.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 juin 1988
    Livré le 22 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bridge end saw mills boathouse lane stockton on tees cleveland. Title no ce 60319.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 16 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 10 sept. 1984
    Livré le 14 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 16 janv. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 06 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0