TEN ALPS RMA LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TEN ALPS RMA LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01743972 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TEN ALPS RMA LIMITED ?
Adresse du siège social | Kings House Royal Court SK11 7AE Macclesfield Brook Street England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TEN ALPS RMA LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2015 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TEN ALPS RMA LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation | |
---|---|
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 juil. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour TEN ALPS RMA LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Trelawney House Chestergate Macclesfield Cheshire SK11 6DW à Kings House Royal Court Macclesfield Brook Street SK11 7AE le 07 avr. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nitil Patel en tant que directeur le 26 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr David James Galan en tant qu'administrateur le 04 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nitil Patel en tant que secrétaire le 26 févr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr David James Galan en tant que secrétaire le 26 févr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2014 au 30 juin 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Derek Morren en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 12 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Adrian Dunleavy en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed inspire creative and media (fareham) LIMITED\certificate issued on 16/01/12 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed inspire creatve and media (fareham) LIMITED\certificate issued on 05/01/12 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed interact creative and media LIMITED\certificate issued on 05/01/12 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TEN ALPS RMA LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALAN, David James | Secrétaire | Royal Court SK11 7AE Macclesfield Kings House Brook Street England | 205540460001 | |||||||
GALAN, David James | Administrateur | Royal Court SK11 7AE Macclesfield Kings House Brook Street England | United Kingdom | British | Company Director | 96736480002 | ||||
ALLEN, Trudy Ann | Secrétaire | Klana Cyprus Road Titchfield Common PO14 4LA Fareham Hampshire | British | Accounts Manager | 80892340001 | |||||
DAVIES, James Ralph Parnell | Secrétaire | 23 Hampden Avenue HP5 2HL Chesham Buckinghamshire | British | 47335710003 | ||||||
GORDON, Timothy Dale | Secrétaire | Silvermead Cottage Green Lane GU24 8PH Chobham Surrey | American | 7582420001 | ||||||
HUGHES, Richard Michael | Secrétaire | 20 St Georges Road GU9 8NB Farnham Surrey | English | Finance Director | 44146590002 | |||||
MABER, Cecelia Dolores, Dr | Secrétaire | Fairview 3 Woodlands PO16 8UH Fareham Hampshire | British | 19450380001 | ||||||
PATEL, Nitil | Secrétaire | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | British | Director | 126644210001 | |||||
PATEL, Nitil | Secrétaire | 6 Alfriston Road SW11 6NN London | British | 126644210001 | ||||||
RANFORD, Paul Frederick | Secrétaire | Bacombe Beeches 89 Ellesborough Road Wendover HP22 6ES Aylesbury Buckinghamshire | British | Finance Director | 35512360002 | |||||
SAMJI, Munir Akberali | Secrétaire | 1 Lynford Close EN5 3HQ Barnet Hertfordshire | United Kingdom | 119498620001 | ||||||
CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 22 Melton Street NW1 2BW London | 38636470004 | |||||||
CLARIDGE, Michael Alan | Administrateur | 14 Arundel Road PO33 1BN Ryde Isle Of Wight | British | Advertising Account Executive | 19450390001 | |||||
CONNOCK, Alexander Michael | Administrateur | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 48562450004 | ||||
CORNEY, Lester William David | Administrateur | Chaucers Puttenham Road Seale GU10 1HP Farnham Surrey | England | British | Company Director | 41244690001 | ||||
DUNLEAVY, Adrian James | Administrateur | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 112236910001 | ||||
HIGGINS, Michael Luke | Administrateur | 58 Romsey Avenue PO16 9TA Fareham Hampshire | England | British | Media Director | 108251770001 | ||||
HUGHES, Richard Michael | Administrateur | 20 St Georges Road GU9 8NB Farnham Surrey | England | English | Finance Director | 44146590002 | ||||
LIDDELL, Barbara Hope | Administrateur | 14 Burridge Road Burridge SO13 1BY Southampton | British | Deputy Managing Director | 81100710002 | |||||
MABER, Cecelia Dolores, Dr | Administrateur | Fairview 3 Woodlands PO16 8UH Fareham Hampshire | British | Scientist | 19450380001 | |||||
MABER, Roger Neil | Administrateur | Great Posbrook Posbrook Lane PO14 4EZ Titchfield Hampshire | England | British | Managing Director | 149030960001 | ||||
MORREN, Derek Alexander | Administrateur | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 114001580002 | ||||
PATEL, Nitil | Administrateur | Chestergate SK11 6DW Macclesfield Trelawney House Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 126644210001 | ||||
RANFORD, Paul Frederick | Administrateur | Bacombe Beeches 89 Ellesborough Road Wendover HP22 6ES Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Director | 35512360002 | ||||
RUBINS, Jack | Administrateur | 34 Northwick Circle HA3 0EE Harrow Middlesex | British | Company Director | 9670450001 | |||||
SMITH, Clive Ronald | Administrateur | Lukes Farm Maurys Lane West Wellow SO51 6DA Romsey Hampshire | British | Director | 26650630002 | |||||
STILL, Charles Andrew Robert | Administrateur | 29 The Avenue N10 2QE London | United Kingdom | British | Company Director | 1807190001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TEN ALPS RMA LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten Alps Plc | 06 avr. 2016 | Bressenden Place SW1E 5BH London 13th Floor, Portland House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
TEN ALPS RMA LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 31 janv. 2011 Livré le 01 févr. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the principals to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any right title or interest in or to any credit balance being any sum standing to the credit of the account, whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 mars 2006 Livré le 08 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 07 mai 1998 Livré le 14 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 11 avr. 1995 Livré le 27 avr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 déc. 1984 Livré le 16 janv. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 194 west street fareham hants. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0