NORTHERN ESTATES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTHERN ESTATES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01748680
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTHERN ESTATES LTD ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe NORTHERN ESTATES LTD ?

    Adresse du siège social
    Greg's Building
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORTHERN ESTATES LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    B + S (PRECAST) LIMITED03 nov. 198603 nov. 1986
    CHAIM YANKEL LIMITED30 août 198330 août 1983

    Quels sont les derniers comptes de NORTHERN ESTATES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTHERN ESTATES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de compte final avant dissolution

    22 pagesWU15
    YC1ALP8H

    Avis de révocation du liquidateur par le tribunal

    13 pagesWU14
    ABB6DOOW

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    22 pagesWU07
    YAVJE26Q

    Nomination d'un liquidateur

    3 pagesWU04
    AAANO1VF

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    20 pagesWU07
    Y9X48BBU

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    4 pagesLIQ MISC
    A98SDZCZ

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    22 pagesWU07
    A8X50961

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    27 pagesWU07
    A7L9DDJ4

    Rapport d'avancement dans une liquidation par le tribunal

    30 pagesWU07
    A6YHTSBD

    Changement d'adresse du siège social de Cg & Co 17 st. Anns Square Manchester M2 7PW à Greg's Building 1 Booth Street Manchester M2 4DU le 02 janv. 2018

    2 pagesAD01
    A6LQ11UI

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04
    A6G0IWOZ

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:liquidators annual progress report to 29/11/2016
    15 pagesLIQ MISC
    Q5LYD5HH

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 22 juil. 2016

    2 pages3.6
    A5EHBVEY

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02
    A5F75W6I

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01
    A5F75W6A

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02
    A5F75W5E

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01
    A5F75W5M

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP
    Q4LGMGQH

    Changement d'adresse du siège social de The Flint Glass Works Jersey Street Manchester M4 6JW à 17 st. Anns Square Manchester M2 7PW le 14 déc. 2015

    2 pagesAD01
    A4LLE0BF

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    pagesCOCOMP
    Q4LGMGQH

    Nomination d'un liquidateur

    1 pages4.31
    A4LLE0C3

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP
    Q4LGMGQH

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2014

    16 pagesAA
    A44D12SH

    Qui sont les dirigeants de NORTHERN ESTATES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EZAIR, Jacob Azouri
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Greg's Building
    Administrateur
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    Greg's Building
    United KingdomBritishDirector8309190002
    BENSON, Debora
    8 Mallard Close
    Offerton
    SK2 5UG Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    8 Mallard Close
    Offerton
    SK2 5UG Stockport
    Cheshire
    British31941100001
    EZAIR, Aaron Richard
    Flat 5
    12 Maple Avenue
    M21 8BD Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire
    Flat 5
    12 Maple Avenue
    M21 8BD Manchester
    Greater Manchester
    BritishMusician80242550001
    EZAIR, Nathan Joshua
    c/o Mr Jacob Azouri Ezair
    64 Jersey Street
    M4 6JW Manchester
    The Flint Glass Works
    England
    Secrétaire
    c/o Mr Jacob Azouri Ezair
    64 Jersey Street
    M4 6JW Manchester
    The Flint Glass Works
    England
    British74586480001
    EZAIR, Sheila
    Bollin Hey
    Collar House Drive
    SK10 4AP Prestbury
    Cheshire
    Secrétaire
    Bollin Hey
    Collar House Drive
    SK10 4AP Prestbury
    Cheshire
    British16747260001
    HAWLEY, Philip
    159 Turncroft Lane
    Offerton
    SK1 4AX Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    159 Turncroft Lane
    Offerton
    SK1 4AX Stockport
    Cheshire
    BritishI T Manager72887040001
    ROSENTHAL, Isaiah Zusman
    73 Cavendish Road
    M7 4NQ Salford
    Lancashire
    Secrétaire
    73 Cavendish Road
    M7 4NQ Salford
    Lancashire
    British75135810001
    EZAIR, Ellis
    Bollin Hey
    Collar House Drive
    SK10 4AP Prestbury
    Cheshire
    Administrateur
    Bollin Hey
    Collar House Drive
    SK10 4AP Prestbury
    Cheshire
    BritishCompany Director89489000001
    EZAIR, Nathan Joshua
    c/o Mr Jacob Azouri Ezair
    64 Jersey Street
    M4 6JW Manchester
    The Flint Glass Works
    England
    Administrateur
    c/o Mr Jacob Azouri Ezair
    64 Jersey Street
    M4 6JW Manchester
    The Flint Glass Works
    England
    United KingdomBritishProperty Developer74586480002
    EZAIR, Sheila
    Bollin Hey
    Collar House Drive
    SK10 4AP Prestbury
    Cheshire
    Administrateur
    Bollin Hey
    Collar House Drive
    SK10 4AP Prestbury
    Cheshire
    BritishDirector16747260001
    TAYLOR, Ann
    60 Longford Road West
    Reddish
    SK5 6ET Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    60 Longford Road West
    Reddish
    SK5 6ET Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant118676590001

    NORTHERN ESTATES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 09 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H parcel of land k/a 20 rena court sparth lane heaton norris stockport.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 2005
    Livré le 25 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    1 curzon avenue, manchester. T/no LA175594 and all the fixtures, the income from time to time, the proceeds of any disposal in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 29 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    405 & 423 gordon road, reddish, stockport, t/n gm 391729, 8& 30 whiley street, manchester, t/n LA49989, 118 dickenson road, manchester t/n LA369444 and 38 osbourne road, levenshulme, manchester t/n GM122176 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 310 sept. 2016Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 310 sept. 2016Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 310 sept. 2016Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 310 sept. 2016Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 3
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 23 juil. 2002
    Livré le 01 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Current account numbered 00837393. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 2002Enregistrement d'une charge (395)

    NORTHERN ESTATES LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 juil. 2022Conclusion of winding up
    17 juil. 2015Petition date
    12 nov. 2015Commencement of winding up
    25 juil. 2023Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jonathan Avery-Gee
    17 St Anns Square
    M2 7PW Manchester
    practitioner
    17 St Anns Square
    M2 7PW Manchester
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    practitioner
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    Stephen Leonard Conn
    Cg & Co 17 St Anns Square
    M2 7PW Manchester
    practitioner
    Cg & Co 17 St Anns Square
    M2 7PW Manchester
    Edward Avery-Gee
    Cg & Co Gregs Building
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    practitioner
    Cg & Co Gregs Building
    1 Booth Street
    M2 4DU Manchester
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Dean Watson
    2-3 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    receiver manager
    2-3 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    Paul Stanley
    Begbies Traynor 1 Winckley Court
    Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    receiver manager
    Begbies Traynor 1 Winckley Court
    Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Steven John Williams
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    receiver manager
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0