RM PLC
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RM PLC |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société anonyme cotée en bourse |
| Numéro de société | 01749877 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RM PLC ?
| Adresse du siège social | 142b Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon Oxon England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RM PLC ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 nov. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mai 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RM PLC ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 janv. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 07 févr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 janv. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour RM PLC ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Link Group 10th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL England à Mufg Corporate Markets Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 14 oct. 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Inscription de la charge 017498770008, créée le 23 juin 2025 | 35 pages | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Inscription de la charge 017498770009, créée le 23 juin 2025 | 69 pages | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 30 nov. 2024 | 198 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 4 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 30 nov. 2023 | 220 pages | AA | ||||||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 janv. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Patrick Neil Martell en tant que directeur le 31 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Mr Daniel Fattal en tant que secrétaire le 06 nov. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Howard Rubenstein en tant que secrétaire le 06 nov. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Ms Carolyn Dawson en tant qu'administrateur le 01 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Mr James Nicholas Murray Wells en tant qu'administrateur le 01 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Edward Bligh en tant que directeur le 31 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Victoria Karen Griffiths en tant que directeur le 06 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Mr Simon Goodwin en tant qu'administrateur le 29 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomination de Mr Christopher John Humphrey en tant qu'administrateur le 07 juil. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Statuts | 72 pages | MA | ||||||||||||||||||||||
Inscription de la charge 017498770006, créée le 05 mai 2023 | 75 pages | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Inscription de la charge 017498770007, créée le 05 mai 2023 | 40 pages | MR01 | ||||||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RM PLC ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATTAL, Daniel | Secrétaire | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | 315565360001 | |||||||
| COOK, Mark | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 154617450001 | |||||
| DAWSON, Carolyn | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 264571450001 | |||||
| GOODWIN, Simon Michael | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 180053770001 | |||||
| HUMPHREY, Christopher John | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 32877720005 | |||||
| MURRAY WELLS, James Nicholas | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British,American | 241726270002 | |||||
| SMOTHERS, Richard | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 303767740001 | |||||
| STEVENSON, Helen Claire | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 169113890001 | |||||
| BROWN, Robin | Secrétaire | 22 Newland OX8 6JF Witney Oxfordshire | British | 31668460001 | ||||||
| DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Secrétaire | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | British | 169922810001 | ||||||
| GREIG, Michael David | Secrétaire | Yew Tree Barn The Paddocks Main Street OX12 0HX East Hanney Oxfordshire | British | 24411590005 | ||||||
| LAGLER, Mark | Secrétaire | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | 263185760001 | |||||||
| MEYER, Caroline Anne Winstone | Secrétaire | Rathlyn Love Lane Donnington RG13 2JG Newbury Berkshire | British | 6714680001 | ||||||
| ROBSON, Andrew John | Secrétaire | The Old Post House Broad Street, Uffington SN7 7RA Faringdon Oxfordshire | British | 292046690001 | ||||||
| RUBENSTEIN, Howard | Secrétaire | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | 305877350001 | |||||||
| WHITCHER, Ashley Paul | Secrétaire | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | 303615180001 | |||||||
| ADONIS, Andrew | Administrateur | Eastern Avenue, Milton Park Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | 75579040003 | |||||
| BERRY, Mark Ian James | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | English | 283870750001 | |||||
| BLIGH, Charles Edward | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 257010950001 | |||||
| BLUNDELL, Andrew Martin | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | United Kingdom | British | 140862520001 | |||||
| BRIGHOUSE, Timothy Robert Peter, Sir | Administrateur | Willow Bank Old Road Shotcover Headington OX3 8TA Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 72445410001 | |||||
| BRIGHOUSE, Timothy Robert Peter, Sir | Administrateur | Willow Bank Old Road Shotcover Headington OX3 8TA Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 72445410001 | |||||
| BROOKS, David John | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 154909100001 | |||||
| BURRELL, Mark William | Administrateur | Bakers Farm Shipley RH13 7JJ Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 7567820002 | |||||
| CARSBERG, Bryan Victor, Sir | Administrateur | 14 The Great Quarry GU1 3XN Guildford Surrey | United Kingdom | British | 48800040001 | |||||
| CONNELL, Josephine Lilian | Administrateur | St. Margarets Great Gaddesden HP1 3BZ Hemel Hempstead Brock House Hertfordshire | England | British | 16992120003 | |||||
| COUTU, Sherry Leigh, Cbe | Administrateur | Middlefield Off Hinton Way, Great Shelford CB22 5AN Cambridge Cambridgeshire | United Kingdom | Canadian | 63909860004 | |||||
| DEAN, Paul David | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 78059050002 | |||||
| FISCHER, Michael David | Administrateur | Wyford Road RG4 9HY Wyford Wyfold Meadows Farm Reading | England | British | 66235580005 | |||||
| GIRLING, Richard Arthur Graham | Administrateur | Heath Farm House NN13 5SN Cottisford Northamptonshire | England | British | 151764260001 | |||||
| GIRLING, Richard Arthur Graham | Administrateur | Heath Farm House NN13 5SN Cottisford Northamptonshire | England | British | 151764260001 | |||||
| GREIG, Michael David | Administrateur | College Farm House College Farm OX13 5PF Garford Oxfordshire | United Kingdom | British | 137046450002 | |||||
| GRIFFITHS, Victoria Karen | Administrateur | Park Drive Milton Park OX14 4SE Abingdon 142b Oxon England | England | British | 252280350001 | |||||
| HARRISON, Michael Geoffrey | Administrateur | Clive House Portsmouth Road KT10 9LH Esher Surrey | Great Britain | British | 42238790001 | |||||
| LEIGHFIELD, John Percival | Administrateur | 91 Victoria Road OX2 7QG Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 8160010001 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0