MHL REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMHL REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01756338
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MHL REALISATIONS LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe MHL REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Four
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MHL REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MCCANN HOMES LIMITED28 déc. 200028 déc. 2000
    MCCANN HOLDINGS LIMITED15 nov. 198315 nov. 1983

    Quels sont les derniers comptes de MHL REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MHL REALISATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MHL REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    19 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 mai 2015

    15 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 mai 2014

    19 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 mai 2013

    19 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 mai 2012

    21 pages4.68

    Cessation de la nomination de Robert David Green en tant que directeur le 17 mai 2011

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert David Green en tant que secrétaire le 17 mai 2011

    2 pagesTM02

    Certificat de changement de nom

    Company name changed mccann homes LIMITED\certificate issued on 02/09/11
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Changement d'adresse du siège social de Shirwell House Shirwell Crescent Furzton Lake Milton Keynes Buckinghamshire MK4 1GA le 14 juin 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    legacy

    5 pagesMG01

    Cessation de la nomination de Simon Langford en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2010

    21 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 oct. 2010

    État du capital au 21 oct. 2010

    • Capital: GBP 50,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Simon David Langford le 31 août 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2009

    22 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    Cessation de la nomination de Charles Raikes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edwin Barnes en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MHL REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COULL, Andrew
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    Administrateur
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    EnglandBritish117328610001
    ROYDON, Terry Rene
    Kingsmill
    The Marlins
    HA6 3NP Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Kingsmill
    The Marlins
    HA6 3NP Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish2326110001
    SETH, David Peter
    1 Brough Close
    Shenley Church End
    MK5 6HR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Brough Close
    Shenley Church End
    MK5 6HR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    UkBritish75931260001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Secrétaire
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    British76720550003
    LEWIS, Pauline Sau Yoke
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    Secrétaire
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    British107739250001
    MCCANN, Jeanette Marie
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    Secrétaire
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    British40380650002
    BARNES, Edwin Sidney
    121 Arlesey Road
    Stotfold
    SG5 4HE Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    121 Arlesey Road
    Stotfold
    SG5 4HE Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish116515140001
    COULL, Andrew
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    Administrateur
    1 Lime Grove
    LU7 2SU Linslade
    Bedfordshire
    EnglandBritish117328610001
    DAVIES, Gail
    5 Lexden Close
    Wootton
    NN4 6DU Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    5 Lexden Close
    Wootton
    NN4 6DU Northampton
    Northamptonshire
    British124910160001
    GAYTON, Paul
    2 Robinson Close
    EN2 6SF Enfield
    Middlesex
    Administrateur
    2 Robinson Close
    EN2 6SF Enfield
    Middlesex
    British125227660001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Administrateur
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritish76720550003
    LANGFORD, Simon David
    10 Woodpecker Way
    SG19 2SQ Sandy
    Bedfordshire
    Administrateur
    10 Woodpecker Way
    SG19 2SQ Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritish117328730001
    LEWIS, Pauline Sau Yoke
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    Administrateur
    7 Broughton Avenue
    LU5 6BQ Toddington
    Bedfordshire
    EnglandBritish107739250001
    MCCANN, James Christopher
    The Oaks
    Heath Lane, Woburn Sands
    MK17 8TS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Oaks
    Heath Lane, Woburn Sands
    MK17 8TS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish50515850006
    MCCANN, Jeanette Marie
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    Administrateur
    Linford Lodge
    Wood Lane St Leger Drive
    MK14 5AZ Great Linford
    Milton Keynes
    United KingdomBritish40380650002
    MCCANN, Malcolm John
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Administrateur
    Branscome Mentmore Road
    Linslade
    LU7 Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British16912730001
    MCCANN, Terence Patrick
    Linford Lodge Wood Lane
    St Leger Drive Great Linford
    MK14 5AZ Milton Keynes
    Administrateur
    Linford Lodge Wood Lane
    St Leger Drive Great Linford
    MK14 5AZ Milton Keynes
    United KingdomBritish8524640002
    PAYTON, Keith Douglas
    4 Heather Breea Gardens
    NN10 6EH Rushden
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Heather Breea Gardens
    NN10 6EH Rushden
    Northamptonshire
    British85234370001
    POWELL, Ashley Jonathan
    152 Lupin Drive
    CM1 6FJ Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    152 Lupin Drive
    CM1 6FJ Chelmsford
    Essex
    British127633390001
    RAIKES, Charles Robert
    51 Mill Street
    OX2 0AL Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    51 Mill Street
    OX2 0AL Oxford
    Oxfordshire
    British127633250001
    ROWNTREE, Charles James
    55 Galleon Way
    ME2 4GX Upnor
    Kent
    Administrateur
    55 Galleon Way
    ME2 4GX Upnor
    Kent
    British100843060001

    MHL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 25 janv. 2011
    Livré le 08 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The land being 42 to 48 (even) oxenhope way borughton milton keynes (plots 1 to 4).
    Personnes ayant droit
    • Homes and Communities Agency
    Transactions
    • 08 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 20 janv. 2010
    Livré le 29 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Plots 53 to 56 cedar park broughton milton keynes.
    Personnes ayant droit
    • Homes and Communities Agency
    Transactions
    • 29 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 2008
    Livré le 02 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a f/h land on the west side of station road, sandy, bedfordshire t/no BD151438, fixed charge all proceeds of sale of the property and all fittings on the property and floating charge all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for the Secured Parties (Security Trustee)
    Transactions
    • 02 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 18 juin 2008
    Livré le 25 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property being building 2, caldecotte lakeside, monellan grove, caldecotte, milton keynes.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 04 juin 2008
    Livré le 13 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H building 1 caldecotte lakeside monellan grove caldecotte milton keynes fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 04 juin 2008
    Livré le 13 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land lying to the north and west of monellan grove caldecotte milton keynes fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 16 mai 2008
    Livré le 04 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Blocks b,c and d monkston park 1 and 2 milton keynes.
    Personnes ayant droit
    • Commission for the New Towns (Known as English Partnerships)of Central Business Exchange
    Transactions
    • 04 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 09 nov. 2007
    Livré le 13 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land at green farm road newport pagnell buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2009
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 2007
    Livré le 13 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land on the west side of garden hedge leighton buzzard bedfordshire t/no BD254941.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 05 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H monkston park sites 1 and 2 milton keynes.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 oct. 2006
    Livré le 24 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the parent to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transactions
    • 24 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 01 août 2006
    Livré le 10 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    120 potton road biggleswade and land and buildings at potton road biggleswade t/n BD12242 and BD146754. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 28 juil. 2006
    Livré le 03 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    193 cressex road, high wycombe.
    Personnes ayant droit
    • Private Sector Developments Limited
    Transactions
    • 03 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 juin 2006
    Livré le 20 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at jordans yard st neots road sandy bedfordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub charge
    Créé le 04 mai 2006
    Livré le 17 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All principal interest or other money now and in the future secured by the mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge over agreement for lease
    Créé le 04 mai 2006
    Livré le 13 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The agreement for lease dated 20TH march 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 2006
    Livré le 13 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property situate at caldecotte lakeside milton keynes. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 avr. 2006
    Livré le 13 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The white swan public house 27 high street westcott bucks. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 13 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H properties k/a plots 25-30 willows chase, monkston park 13 & 14, milton keynes t/no. BM61781.
    Personnes ayant droit
    • Commission for the New Towns
    Transactions
    • 13 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 2005
    Livré le 02 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land off trow close, cotton end, bedfordshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 août 2005
    Livré le 26 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land being 55,57 and 59 stoke road slough t/n BK234902 BK362460 and BK277664. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 16 juin 2005
    Livré le 06 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the south west of tewkesbury lane monkston park milton keynes t/lybm 291292. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 juin 2005
    Livré le 06 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the south west of tewkesbury lane monkston park milton keynes t/n bm 291292. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of performance bond
    Créé le 07 déc. 2004
    Livré le 23 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The benefit of a performance bond between kingsoak homes limited, hsbc bank PLC and the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 déc. 2004
    Livré le 09 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/Hold land and buildings lying to the west of plantation rd,leighton buzzard with all buildings and other structures thereon; the goodwill of business and all plant machinery and other items affixed thereon; the proceeds of any claims made under any insurance policy. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)

    MHL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 mai 2011Commencement of winding up
    19 avr. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0