M.E.S. GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéM.E.S. GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01770514
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de M.E.S. GROUP LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe M.E.S. GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de M.E.S. GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INSPECTORATE M.E.S. LIMITED25 juin 198725 juin 1987
    M.E.S. GROUP LIMITED29 déc. 198329 déc. 1983
    DIRECTMINSTER LIMITED16 nov. 198316 nov. 1983

    Quels sont les derniers comptes de M.E.S. GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour M.E.S. GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 mars 2011

    4 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 45 Bowesfield Lane Stockton-on-Tees TS18 3YH England le 13 oct. 2010

    1 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 août 2010

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    État du capital après une attribution d'actions au 19 août 2010

    • Capital: GBP 1,747,224
    4 pagesSH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Abigail Silk le 19 avr. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    1 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    1 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    1 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    1 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de M.E.S. GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SILK, Abigail
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    England
    Secrétaire
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    England
    British131841500001
    MORRISON, Neil Steven
    PO BOX 115215
    Dubai
    Uae
    Administrateur
    PO BOX 115215
    Dubai
    Uae
    United Arab EmiratesBritish103664250003
    WESTWOOD, Alexander
    PO BOX 115215
    FOREIGN Dubai
    Uae
    Administrateur
    PO BOX 115215
    FOREIGN Dubai
    Uae
    United Arab EmiratesBritish67088470010
    BANYARD, Alec William James
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    Secrétaire
    17 Hampstead Gardens
    SS5 5HN Hockley
    Essex
    British32189370001
    MILNE, Michael Mckenzie
    5 Birkwood Place
    Mearnskirk
    G77 5FW Glasgow
    Secrétaire
    5 Birkwood Place
    Mearnskirk
    G77 5FW Glasgow
    British59129940001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Scotland
    Secrétaire
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Scotland
    38777080002
    ALLAN, Derek Macdonald
    37 Bernham Avenue
    AB39 2WD Stonehaven
    Administrateur
    37 Bernham Avenue
    AB39 2WD Stonehaven
    British63077290001
    COWPERTHWAITE, Graham
    Greenleas Old Inn Road
    Findon Portlethen
    AB1 4RN Aberdeen
    Administrateur
    Greenleas Old Inn Road
    Findon Portlethen
    AB1 4RN Aberdeen
    British44329870001
    EVANS, John Patrick
    The Shambles
    14 Kinnaird Way
    CB1 8SN Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    The Shambles
    14 Kinnaird Way
    CB1 8SN Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish48846930001
    FARRELLY, Barry Brenden
    38 The Grove
    RM14 2ET Upminster
    Essex
    Administrateur
    38 The Grove
    RM14 2ET Upminster
    Essex
    United KingdomBritish1243520001
    GOODWIN, Adrian Jonathan
    1 Culter Den
    Peterculter
    AB1 0WA Aberdeen
    Administrateur
    1 Culter Den
    Peterculter
    AB1 0WA Aberdeen
    United KingdomBritish32383580002
    HUME, Charles Robert
    Pitfold
    Hurtmore Road
    GU7 2RB Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Pitfold
    Hurtmore Road
    GU7 2RB Godalming
    Surrey
    EnglandBritish41834070001
    MILNE, Peter John
    Craigwood
    Blairs
    AB12 5YT Aberdeen
    Administrateur
    Craigwood
    Blairs
    AB12 5YT Aberdeen
    ScotlandBritish33613400008
    RUSSELL, Malcolm
    17 Dover Beck Close
    Ravenshead
    NG15 9ER Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    17 Dover Beck Close
    Ravenshead
    NG15 9ER Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish65095960001

    M.E.S. GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 mars 1989
    Livré le 10 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade and tenants fixture). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of offset
    Créé le 21 mars 1989
    Livré le 10 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of mes group limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 sept. 1988
    Livré le 27 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or inspectorate UK holdings limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Land & buildings situate at rotterdam road, lowestoft suffolk, title no.sk 72773.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 juin 1986
    Livré le 18 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises at rotterdam road & norwich road lowestoft 82/83 exmouth road great yarmouth norfolk 36,37,38 nelson road south great yarmouth norfolk fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Trust Company of Canada
    Transactions
    • 18 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 avr. 1984
    Livré le 02 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 mai 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1984
    Livré le 16 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings fronting rotterdam road and norwich road lowestoft suffolk.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1984
    Livré le 16 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 82/83 exmouth road grt.yarmouth norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 27 janv. 1984
    Livré le 16 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H st davids hotel 36-38 nelson road south grt.yarmouth norfolk.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1984Enregistrement d'une charge

    M.E.S. GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 août 2010Commencement of winding up
    21 juin 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Bernard Stephen
    Bdo Llp, 4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    practitioner
    Bdo Llp, 4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0