GREETINGS FOR EATING LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREETINGS FOR EATING LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01770733
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREETINGS FOR EATING LTD ?

    • (1584) /

    Où se situe GREETINGS FOR EATING LTD ?

    Adresse du siège social
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GREETINGS FOR EATING LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WELLSPRINGS CONFECTIONERY LIMITED05 avr. 199305 avr. 1993
    WELLSPRINGS ENTERPRISES LIMITED 17 oct. 198817 oct. 1988
    BETHCAR LIMITED02 oct. 198602 oct. 1986
    BETHCAR AGRICULTURE LIMITED17 nov. 198317 nov. 1983

    Quels sont les derniers comptes de GREETINGS FOR EATING LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour GREETINGS FOR EATING LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 nov. 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mai 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 nov. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mai 2009

    5 pages4.68

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    66 pages2.17B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    26 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    68 pages2.23B

    Déclaration des affaires

    31 pages2.16B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2006

    12 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2005

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Qui sont les dirigeants de GREETINGS FOR EATING LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMITH, Yasmin Ruth
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    British60088530001
    SMITH, James Michael, Dr
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish150413640001
    SMITH, Stephen David, Dr
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    British54545850002
    SMITH, Yasmin Ruth
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Woodlands Main Street
    Kirton
    NG22 9LP Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish60088530001
    JOHN, Josh Verghese
    24 Orchard Crescent
    Tuxford
    NG22 0LU Newark
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    24 Orchard Crescent
    Tuxford
    NG22 0LU Newark
    Nottinghamshire
    British51340860001
    PRICE, Gregory Philip
    15 Hill Vue Avenue
    NG24 1PQ Newark
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    15 Hill Vue Avenue
    NG24 1PQ Newark
    Nottinghamshire
    British15769230004
    BOWER, Stuart Richard Hugo
    4 Long Lane
    Tuxford
    NG22 0LS Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    4 Long Lane
    Tuxford
    NG22 0LS Newark
    Nottinghamshire
    British73425870001
    BUTTERFIELD, Marcel
    Canterbury Lodge
    Rempstone Road Coleorton
    LE67 8HR Coalville
    Leicestershire
    Administrateur
    Canterbury Lodge
    Rempstone Road Coleorton
    LE67 8HR Coalville
    Leicestershire
    United KingdomBritish61153960003
    COMMUNITY OF THE TRUE VINE LTD, The Directors
    Beth Shalon
    Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Beth Shalon
    Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    British15769240001
    FORD, Glen
    9 Churchill Drive
    Hilton
    DE65 5FS Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    9 Churchill Drive
    Hilton
    DE65 5FS Derby
    Derbyshire
    British103152550001
    SMITH, James Michael, Dr
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Cocking Hill House
    Tuxford Road Boughton
    NG22 9LB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish150413640001
    SMITH, Marina Helen
    Bethany Acres Road Edge
    Ollerton Road Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Bethany Acres Road Edge
    Ollerton Road Laxton
    NG22 0PA Newark
    Nottinghamshire
    British9654780004

    GREETINGS FOR EATING LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Chattel mortgage
    Créé le 30 nov. 2005
    Livré le 02 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The equipment being marden edwards overwrapper s/n 7424, loma combi metal detector s/n ACB43046-38591F and rondo compas icing roller s/n C4A421102 for details of further chattels charged please refer to form 395, fixed charge on all policies of insurance and all rights and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 08 déc. 2004
    Livré le 11 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 05 mars 2003
    Livré le 15 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 15 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 03 juil. 2000
    Livré le 04 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies and all other liabilities due or to become due from the company to the chargee and all costs and expenses incurred in relation to the charge on a full indemnity basis together with interest thereon
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge all the book debts and other debts of the company which are not charged hereunder by way of fixed charge.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance Limited (The Charge Holder)
    Transactions
    • 04 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 mars 1998
    Livré le 27 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 1998
    Livré le 15 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,378 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Qualitec food depositor with pump action. All stainless steel electro 16RAK oven with thermo/steam injection, ebat crypto peerless food mixer and accessories, frigoscandia giro spiral cake drying tunnel, qualitech deposit.
    Personnes ayant droit
    • North Nottinghamshire Training & Enterprise Council Limited
    Transactions
    • 15 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 janv. 1998
    Livré le 15 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,378 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all the plant machinery vehicles stock and shares and all other similar property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital fixtures and fittings.
    Personnes ayant droit
    • North Nottinghamshire Training & Enterprise Council Limited
    Transactions
    • 15 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 févr. 1996
    Livré le 07 févr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £5,000 under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Qualitec food depositor with pump action all stainless steel electro 16RAK oven with thermo/steam injection (3 phase) eb 80 crypto peerless food mixer and accessories.
    Personnes ayant droit
    • North Nottinghamshire Training and Enterprise Council Limited
    Transactions
    • 07 févr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GREETINGS FOR EATING LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mai 2008Administration ended
    04 juin 2007Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Franklin Plant
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    practitioner
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    Daniel Plant
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    practitioner
    9 Ensign House
    Admirals Way
    E14 9XQ Marsh Wall
    London
    2
    DateType
    15 févr. 2011Dissolved on
    30 mai 2008Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Plant
    Sfp
    9 Ensign House
    E14 9XQ Admirals Way
    Marsh Wall, Docklands London
    practitioner
    Sfp
    9 Ensign House
    E14 9XQ Admirals Way
    Marsh Wall, Docklands London
    Simon Franklin Plant
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London
    practitioner
    Sfp 9 Ensign House
    Admirals Way, Marsh Wall, Docklands
    E14 9XQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0