RH FREEPORT WAREHOUSING LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRH FREEPORT WAREHOUSING LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01771843
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RH FREEPORT WAREHOUSING LTD ?

    • Transport routier de marchandises (49410) / Transports et stockage

    Où se situe RH FREEPORT WAREHOUSING LTD ?

    Adresse du siège social
    Kuehne+Nagel House Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6BW Milton Keynes
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RH FREEPORT WAREHOUSING LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MERSEY FREIGHT SERVICES (MTL) LTD07 août 198507 août 1985
    MERSEY FREIGHT SERVICES LIMITED 22 nov. 198322 nov. 1983

    Quels sont les derniers comptes de RH FREEPORT WAREHOUSING LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour RH FREEPORT WAREHOUSING LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2012

    État du capital au 12 juin 2012

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Tim Scharwath en tant que directeur le 01 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    22 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Lenton Lane Nottingham NG7 2NR le 11 mai 2011

    1 pagesAD01

    Nomination de Tim Scharwath en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Thierry Patrick Held en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Baxter en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Baxter en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven Rafferty en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven Rafferty en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Peter Isler en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Robert Layton en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    11 pagesMG01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    22 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter James Isler le 09 mai 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    19 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de RH FREEPORT WAREHOUSING LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAYTON, Robert
    Sywell Road
    Holcot
    NN6 9SN Northampton
    Nutmeg Cottage
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Sywell Road
    Holcot
    NN6 9SN Northampton
    Nutmeg Cottage
    Northamptonshire
    British159459370001
    HELD, Thierry Patrick
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    Administrateur
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    EnglandSwiss155850310001
    CRANE, Roger Leonard Arthur
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    Secrétaire
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    British18196300002
    RAFFERTY, Steven
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    Secrétaire
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    British86477730001
    BAXTER, Andrew Neville
    Moor House
    Old North Road South Muskham
    NG23 6DX Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Moor House
    Old North Road South Muskham
    NG23 6DX Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107002860001
    BAXTER, Ian John Robert
    Church Lane
    NG13 9HG Langar
    Langar House
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Church Lane
    NG13 9HG Langar
    Langar House
    Nottinghamshire
    EnglandBritish20757760004
    BAXTER, Neville Alfred
    Wellow Park House
    Bleasby
    NG14 7GH Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Wellow Park House
    Bleasby
    NG14 7GH Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish1639600001
    CRANE, Roger Leonard Arthur
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    Administrateur
    19 Gillercomb Close
    West Bridgford
    NG2 6SE Nottingham
    British18196300002
    GOODRICK, Howard Vivian
    Lark Cottage
    West End, Lund
    YO25 9TN Driffield
    North Humberside
    Administrateur
    Lark Cottage
    West End, Lund
    YO25 9TN Driffield
    North Humberside
    EnglandBritish10050160002
    ISLER, Peter James
    Southfield Farm House
    The Clays
    LN5 0RW Brant Broughton
    Lincolnshire
    Administrateur
    Southfield Farm House
    The Clays
    LN5 0RW Brant Broughton
    Lincolnshire
    United KingdomBritish82518660002
    JARVIS, Terence
    27 Chester Avenue
    PR9 7ET Southport
    Merseyside
    Administrateur
    27 Chester Avenue
    PR9 7ET Southport
    Merseyside
    British39724000001
    RAFFERTY, Steven
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    Administrateur
    5a Ashford Road
    LE10 0JL Hinckley
    Leicestershire
    United KingdomBritish86477730001
    SCHARWATH, Tim
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    Administrateur
    Florence Way
    Rockingham Road
    UB8 2LS Uxbridge
    1 Union Business Park
    Middlesex
    EnglandBritish159736860001
    STOKES, Mark Bryan
    Stoneleigh House Main Road
    Anslow
    DE13 9QE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Stoneleigh House Main Road
    Anslow
    DE13 9QE Burton On Trent
    Staffordshire
    British74798060003

    RH FREEPORT WAREHOUSING LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 30 déc. 2010
    Livré le 31 déc. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 2010
    Livré le 21 déc. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 18 févr. 1994
    Livré le 01 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge.
    Créé le 25 juin 1991
    Livré le 15 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge over all book and other debts owing to the company. (For full details see form 395, tc ref: M286C).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 oct. 1988
    Livré le 25 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 1988
    Livré le 13 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The R H Group Limited
    Transactions
    • 13 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 1987
    Livré le 14 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mai 1987Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 03 avr. 1987
    Livré le 07 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing the liability and future potential liability of r h freight (mersey) limited and the R.H. group limited in respect of the rent and covenants contained in 3 sub under-leases dated 20.9.74 22.11.77 & 4.8.78
    Brèves mentions
    First floating charge over the company (see doc). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • R H Freight (Mersey) Limited
    Transactions
    • 07 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 20 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 06 déc. 1985
    Livré le 12 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book & other debts due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 08 juin 1984
    Livré le 13 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over (see doc M15). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 1984Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0